SGKBB LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSGKBB LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02056420
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SGKBB LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SGKBB LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor 8 St James's Square
    SW1Y 4JU London
    England
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SGKBB LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KLEINWORT BENSON BANK LIMITED01 juil. 201001 juil. 2010
    KLEINWORT BENSON PRIVATE BANK LIMITED04 mars 200204 mars 2002
    KLEINWORT BENSON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED01 oct. 198801 oct. 1988
    KLEINWORT GRIEVESON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED18 sept. 198618 sept. 1986

    Quels sont les derniers comptes de SGKBB LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour SGKBB LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 14 août 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de S G Hambros Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 juil. 2017

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Eric Edmund Barnett en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Joanna Catherine Boait en tant que secrétaire le 12 janv. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Konstantin Nikolaus Graf Von Schweinitz en tant que directeur le 27 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jean-Francois Alain Mazaud en tant que directeur le 27 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anne Shirley Ewing en tant que directeur le 27 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stuart Barnett en tant que directeur le 27 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Changement d'adresse du siège social de , 14 st. George Street, London, W1S 1FE à 5th Floor 8 st James's Square London England SW1Y 4JU le 27 nov. 2017

    1 pagesAD01

    État du capital au 06 nov. 2017

    • Capital: GBP 1.0
    3 pagesSH19

    Certificat de réduction du capital émis et de la prime d'émission et annulation de la prime d'émission

    1 pagesCERT17

    legacy

    7 pagesOC138

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    50 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 août 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de SGKBB LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRANSON, Gabrielle Alice
    8 St James's Square
    SW1Y 4JU London
    5th Floor
    England
    England
    Administrateur
    8 St James's Square
    SW1Y 4JU London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish172748970001
    FLAIS, Jean-Pierre Louis
    8 St James's Square
    SW1Y 4JU London
    5th Floor
    England
    England
    Administrateur
    8 St James's Square
    SW1Y 4JU London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish,French61299880004
    AMEY, Michelle
    4 Holme Road
    RM11 3QS Hornchurch
    Essex
    Secrétaire
    4 Holme Road
    RM11 3QS Hornchurch
    Essex
    British57746950002
    BOAIT, Joanna Catherine
    Wayside Wyncombe Close
    Fittleworth
    RH20 1HW Pulborough
    West Sussex
    Secrétaire
    Wayside Wyncombe Close
    Fittleworth
    RH20 1HW Pulborough
    West Sussex
    British62645510001
    CAREY, Henrietta
    Flat 8 Breakspears Road
    SE4 1XW London
    Secrétaire
    Flat 8 Breakspears Road
    SE4 1XW London
    British125124260001
    FROST, Leonora Marian
    5 Launceston Place
    W8 5RL London
    Secrétaire
    5 Launceston Place
    W8 5RL London
    British4299350001
    PARIHAR, Shilpa
    Welland Mews
    Wapping
    E1W 2JW London
    26
    Secrétaire
    Welland Mews
    Wapping
    E1W 2JW London
    26
    British133915290001
    PRUDDEN, Mark Darren
    Heatherwold
    RG20 9BG Burghclere
    Hedgerows
    Berkshire
    Secrétaire
    Heatherwold
    RG20 9BG Burghclere
    Hedgerows
    Berkshire
    British146073160001
    SCHRAGER VON ALTISHOFEN, Nicola Jane
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    British110050670001
    ADAMS, Francis Peter Leslie
    9 Beaulieu Gardens
    Winchmore Hill
    N21 2HR London
    Administrateur
    9 Beaulieu Gardens
    Winchmore Hill
    N21 2HR London
    EnglandBritish29950570001
    ADCOCK, Andrew John
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    England
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    England
    United KingdomBritish135849710001
    AIN, Anthony
    35a Elsworthy Road
    NW3 London
    Administrateur
    35a Elsworthy Road
    NW3 London
    American52007300001
    AINSWORTH, Philip Gee
    12 Thickets
    TN13 3SZ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    12 Thickets
    TN13 3SZ Sevenoaks
    Kent
    British1941840001
    ALFORD, George Francis Onslow
    28 Eagle Wharf
    Lafone Street
    SE1 London
    Administrateur
    28 Eagle Wharf
    Lafone Street
    SE1 London
    British52398760003
    ALLEN, Michael
    36 Windsor Way
    W14 0UA London
    Administrateur
    36 Windsor Way
    W14 0UA London
    British68442020002
    ALLEN, Peter John
    Hestia Woodland Way
    KT20 6PA Kingswood
    Surrey
    Administrateur
    Hestia Woodland Way
    KT20 6PA Kingswood
    Surrey
    EnglandBritish35130830001
    ANDREAE, Peter Maxwell Herman
    13 Pelham Place
    SW7 2NQ London
    Administrateur
    13 Pelham Place
    SW7 2NQ London
    British52839440002
    BABTIE, John William
    30 West Temple Sheen
    SW14 7AP London
    Administrateur
    30 West Temple Sheen
    SW14 7AP London
    British9510820001
    BALIMAN, Michael Raymond
    66 Sutherland Avenue
    Maida Vale
    W9 2QS London
    Administrateur
    66 Sutherland Avenue
    Maida Vale
    W9 2QS London
    British41038250001
    BARKER, Timothy Gwynne
    Thorpe Hall
    Thorpe Morieux
    IP30 0NW Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    Thorpe Hall
    Thorpe Morieux
    IP30 0NW Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish54546720001
    BARNETT, Eric Edmund
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    England
    England
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    England
    England
    United KingdomBritish91709820005
    BARNETT, Stuart
    8 St James's Square
    SW1Y 4JU London
    5th Floor
    England
    England
    Administrateur
    8 St James's Square
    SW1Y 4JU London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish209261080001
    BAYLISS, Keith Ronald
    Fernside Old Christchurch Road
    Everton
    SO41 0JJ Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Fernside Old Christchurch Road
    Everton
    SO41 0JJ Lymington
    Hampshire
    British55337400001
    BEAUMONT, Michael Eric
    Mountfield Warehorne
    TN26 2LP Ashford
    Kent
    Administrateur
    Mountfield Warehorne
    TN26 2LP Ashford
    Kent
    British9705560001
    BEGG, Alastair Currie
    Monks Manor Fir Toll Road
    TN20 6NE Mayfield
    East Sussex
    Administrateur
    Monks Manor Fir Toll Road
    TN20 6NE Mayfield
    East Sussex
    British13324470001
    BLACK, Colin Hyndmarsh
    15 Tudor Close
    Fairmile Park Road
    KT11 2PH Cobham
    Surrey
    Administrateur
    15 Tudor Close
    Fairmile Park Road
    KT11 2PH Cobham
    Surrey
    British482150001
    BLAKE, Laura Kim
    9 Woodbury Hill
    IG10 1JB Loughton
    Essex
    Administrateur
    9 Woodbury Hill
    IG10 1JB Loughton
    Essex
    United KingdomBritish47568410002
    BOECKENFELD, Martha Dagmar
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    England
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    England
    SwitzerlandBritish152570420001
    BOGGISS, Jill Susan
    14 Gartmoor Gardens
    Southfields
    SW19 London
    Administrateur
    14 Gartmoor Gardens
    Southfields
    SW19 London
    British38590440001
    BOSCHKE, Holger
    Schweizer Strasse 24
    FOREIGN Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    Administrateur
    Schweizer Strasse 24
    FOREIGN Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    German123865330001
    BOSCHKE, Holger
    155 Holland Park Avenue
    W11 4UX London
    Administrateur
    155 Holland Park Avenue
    W11 4UX London
    German81150540003
    BOWATER, Nicolas Charles Vansittart
    Flat 3 51 St Georges Square
    SW1V 3QN London
    Administrateur
    Flat 3 51 St Georges Square
    SW1V 3QN London
    British114592540001
    BREWIS, Anthony Charles Errington
    Brook Cottage Sychem Lane
    Five Oak Green
    TN12 6TT Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Brook Cottage Sychem Lane
    Five Oak Green
    TN12 6TT Tonbridge
    Kent
    British62166510001
    BRIDSON, Patricia Margaret
    Salcombe House Spring Road
    AL5 3PP Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Salcombe House Spring Road
    AL5 3PP Harpenden
    Hertfordshire
    British44557160002
    CAVANAGH, Charles Terrence Stephen
    31 The Chase
    SW4 0NP London
    Administrateur
    31 The Chase
    SW4 0NP London
    British/American28962380001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SGKBB LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    One
    United Kingdom
    28 juil. 2016
    Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    One
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07061507
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    St James's Square
    SW1Y 4JU London
    8
    United Kingdom
    28 juil. 2016
    St James's Square
    SW1Y 4JU London
    8
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03470463
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SGKBB LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 27 mai 2010
    Livré le 29 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re kleinwort benson private bank limited and numbered 30-00-02 01950318 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juin 2017L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 01 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Master novation agreement
    Créé le 02 mai 2006
    Livré le 15 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The participant charges all its right, title and interest to and in all deposited instruments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 15 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of priorities and subordination
    Créé le 23 août 1993
    Livré le 26 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the documents referred to in schedule 2 of this charge.
    Brèves mentions
    By way of first fixed cahrge,any money or other asets which the company receives in contravention of clause 5 or clause 7 of the deed of priorities and subordination.
    Personnes ayant droit
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transactions
    • 26 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 04 juin 1993
    Livré le 09 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All shares,stock and other securities of any description.........see form 395.
    Personnes ayant droit
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited"the London Stock Exchange"
    Transactions
    • 09 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplement
    Créé le 24 janv. 1991
    Livré le 31 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a collateral agreement dated 14/7/87
    Brèves mentions
    All the borrowers right title and interest in and to account no 9453117 (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 31 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 02 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Collateral agreement
    Créé le 14 juil. 1987
    Livré le 17 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euro-clear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (for full details see doc).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 17 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 02 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed
    Créé le 06 janv. 1987
    Livré le 20 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's account with and held by morgan guaranty trust company of new york (see doc for full details).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 20 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 02 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0