SGKBB LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SGKBB LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02056420 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SGKBB LIMITED ?
| Adresse du siège social | 5th Floor 8 St James's Square SW1Y 4JU London England England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SGKBB LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour SGKBB LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de S G Hambros Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 juil. 2017 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eric Edmund Barnett en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joanna Catherine Boait en tant que secrétaire le 12 janv. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Konstantin Nikolaus Graf Von Schweinitz en tant que directeur le 27 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jean-Francois Alain Mazaud en tant que directeur le 27 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anne Shirley Ewing en tant que directeur le 27 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Barnett en tant que directeur le 27 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , 14 st. George Street, London, W1S 1FE à 5th Floor 8 st James's Square London England SW1Y 4JU le 27 nov. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
État du capital au 06 nov. 2017
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
Certificat de réduction du capital émis et de la prime d'émission et annulation de la prime d'émission | 1 pages | CERT17 | ||||||||||
legacy | 7 pages | OC138 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 50 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SGKBB LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANSON, Gabrielle Alice | Administrateur | 8 St James's Square SW1Y 4JU London 5th Floor England England | United Kingdom | British | 172748970001 | |||||
| FLAIS, Jean-Pierre Louis | Administrateur | 8 St James's Square SW1Y 4JU London 5th Floor England England | England | British,French | 61299880004 | |||||
| AMEY, Michelle | Secrétaire | 4 Holme Road RM11 3QS Hornchurch Essex | British | 57746950002 | ||||||
| BOAIT, Joanna Catherine | Secrétaire | Wayside Wyncombe Close Fittleworth RH20 1HW Pulborough West Sussex | British | 62645510001 | ||||||
| CAREY, Henrietta | Secrétaire | Flat 8 Breakspears Road SE4 1XW London | British | 125124260001 | ||||||
| FROST, Leonora Marian | Secrétaire | 5 Launceston Place W8 5RL London | British | 4299350001 | ||||||
| PARIHAR, Shilpa | Secrétaire | Welland Mews Wapping E1W 2JW London 26 | British | 133915290001 | ||||||
| PRUDDEN, Mark Darren | Secrétaire | Heatherwold RG20 9BG Burghclere Hedgerows Berkshire | British | 146073160001 | ||||||
| SCHRAGER VON ALTISHOFEN, Nicola Jane | Secrétaire | Oliver House Stud Ched Glow SN16 9EZ Malmesbury Wiltshire | British | 110050670001 | ||||||
| ADAMS, Francis Peter Leslie | Administrateur | 9 Beaulieu Gardens Winchmore Hill N21 2HR London | England | British | 29950570001 | |||||
| ADCOCK, Andrew John | Administrateur | St. George Street W1S 1FE London 14 England | United Kingdom | British | 135849710001 | |||||
| AIN, Anthony | Administrateur | 35a Elsworthy Road NW3 London | American | 52007300001 | ||||||
| AINSWORTH, Philip Gee | Administrateur | 12 Thickets TN13 3SZ Sevenoaks Kent | British | 1941840001 | ||||||
| ALFORD, George Francis Onslow | Administrateur | 28 Eagle Wharf Lafone Street SE1 London | British | 52398760003 | ||||||
| ALLEN, Michael | Administrateur | 36 Windsor Way W14 0UA London | British | 68442020002 | ||||||
| ALLEN, Peter John | Administrateur | Hestia Woodland Way KT20 6PA Kingswood Surrey | England | British | 35130830001 | |||||
| ANDREAE, Peter Maxwell Herman | Administrateur | 13 Pelham Place SW7 2NQ London | British | 52839440002 | ||||||
| BABTIE, John William | Administrateur | 30 West Temple Sheen SW14 7AP London | British | 9510820001 | ||||||
| BALIMAN, Michael Raymond | Administrateur | 66 Sutherland Avenue Maida Vale W9 2QS London | British | 41038250001 | ||||||
| BARKER, Timothy Gwynne | Administrateur | Thorpe Hall Thorpe Morieux IP30 0NW Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 54546720001 | |||||
| BARNETT, Eric Edmund | Administrateur | St. George Street W1S 1FE London 14 England England | United Kingdom | British | 91709820005 | |||||
| BARNETT, Stuart | Administrateur | 8 St James's Square SW1Y 4JU London 5th Floor England England | United Kingdom | British | 209261080001 | |||||
| BAYLISS, Keith Ronald | Administrateur | Fernside Old Christchurch Road Everton SO41 0JJ Lymington Hampshire | British | 55337400001 | ||||||
| BEAUMONT, Michael Eric | Administrateur | Mountfield Warehorne TN26 2LP Ashford Kent | British | 9705560001 | ||||||
| BEGG, Alastair Currie | Administrateur | Monks Manor Fir Toll Road TN20 6NE Mayfield East Sussex | British | 13324470001 | ||||||
| BLACK, Colin Hyndmarsh | Administrateur | 15 Tudor Close Fairmile Park Road KT11 2PH Cobham Surrey | British | 482150001 | ||||||
| BLAKE, Laura Kim | Administrateur | 9 Woodbury Hill IG10 1JB Loughton Essex | United Kingdom | British | 47568410002 | |||||
| BOECKENFELD, Martha Dagmar | Administrateur | St. George Street W1S 1FE London 14 England | Switzerland | British | 152570420001 | |||||
| BOGGISS, Jill Susan | Administrateur | 14 Gartmoor Gardens Southfields SW19 London | British | 38590440001 | ||||||
| BOSCHKE, Holger | Administrateur | Schweizer Strasse 24 FOREIGN Frankfurt Am Main 60594 Germany | German | 123865330001 | ||||||
| BOSCHKE, Holger | Administrateur | 155 Holland Park Avenue W11 4UX London | German | 81150540003 | ||||||
| BOWATER, Nicolas Charles Vansittart | Administrateur | Flat 3 51 St Georges Square SW1V 3QN London | British | 114592540001 | ||||||
| BREWIS, Anthony Charles Errington | Administrateur | Brook Cottage Sychem Lane Five Oak Green TN12 6TT Tonbridge Kent | British | 62166510001 | ||||||
| BRIDSON, Patricia Margaret | Administrateur | Salcombe House Spring Road AL5 3PP Harpenden Hertfordshire | British | 44557160002 | ||||||
| CAVANAGH, Charles Terrence Stephen | Administrateur | 31 The Chase SW4 0NP London | British/American | 28962380001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SGKBB LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhf Group Uk Limited | 28 juil. 2016 | Silk Street EC2Y 8HQ London One United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Sg Kleinwort Hambros Limited | 28 juil. 2016 | St James's Square SW1Y 4JU London 8 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SGKBB LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit agreement to secure own liabilities | Créé le 27 mai 2010 Livré le 29 mai 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re kleinwort benson private bank limited and numbered 30-00-02 01950318 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Master novation agreement | Créé le 02 mai 2006 Livré le 15 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The participant charges all its right, title and interest to and in all deposited instruments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of priorities and subordination | Créé le 23 août 1993 Livré le 26 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the documents referred to in schedule 2 of this charge. | |
Brèves mentions By way of first fixed cahrge,any money or other asets which the company receives in contravention of clause 5 or clause 7 of the deed of priorities and subordination. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 04 juin 1993 Livré le 09 juin 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All shares,stock and other securities of any description.........see form 395. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplement | Créé le 24 janv. 1991 Livré le 31 janv. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a collateral agreement dated 14/7/87 | |
Brèves mentions All the borrowers right title and interest in and to account no 9453117 (for full details see form 395). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Collateral agreement | Créé le 14 juil. 1987 Livré le 17 juil. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euro-clear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (for full details see doc). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed | Créé le 06 janv. 1987 Livré le 20 janv. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions First fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's account with and held by morgan guaranty trust company of new york (see doc for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0