WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 02058427
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC ?

    • (7415) /

    Où se situe WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WATERFORD WEDGWOOD HOLDINGS PLC 21 oct. 198621 oct. 1986
    DAYOFFER PUBLIC LIMITED COMPANY 25 sept. 198625 sept. 1986

    Quels sont les derniers comptes de WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2009
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2009
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    38 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 mai 2016

    46 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 mai 2015

    57 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 mai 2014

    62 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 mai 2013

    58 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:order of court removing angus matthew martin as liquidator of the company
    9 pagesLIQ MISC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 mai 2012

    46 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:form 2.39B notice of vacation of office
    15 pagesLIQ MISC

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    26 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 janv. 2011

    50 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 juil. 2010

    54 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 janv. 2010

    27 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 janv. 2010

    2 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 janv. 2010

    49 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    legacy

    3 pagesMG02

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 juil. 2009

    59 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 juil. 2009

    30 pages2.24B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DOWLING, Patrick John
    21 Raglan Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Secrétaire
    21 Raglan Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Irish29859260001
    DOWNIE, Mark Lindsay
    Bassett Close
    Cheadle
    ST10 1UU Stoke-On-Trent
    17
    Staffordshire
    Secrétaire
    Bassett Close
    Cheadle
    ST10 1UU Stoke-On-Trent
    17
    Staffordshire
    British128949130001
    JENNINGS, Wendy Joy
    189 Aston Village
    Pipe Gate
    TF9 4JF Market Drayton
    Shropshire
    Secrétaire
    189 Aston Village
    Pipe Gate
    TF9 4JF Market Drayton
    Shropshire
    British8248520001
    STONIER, George
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    British8248550001
    ASHWELL, Kneale Holland
    6 Clarence Crescent
    SL4 5DT Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    6 Clarence Crescent
    SL4 5DT Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish52176650002
    BARNES, Richard Anthony
    Hillside Minn Bank
    Willoughbridge
    TF9 4EU Market Drayton
    Shropshire
    Administrateur
    Hillside Minn Bank
    Willoughbridge
    TF9 4EU Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritish9859220001
    BRENNAN, Donald P
    Hoaglands Lane
    Foxmount Farm Old Brookville
    FOREIGN New York 11545
    Usa
    Administrateur
    Hoaglands Lane
    Foxmount Farm Old Brookville
    FOREIGN New York 11545
    Usa
    American29524290001
    D`ALTON, Paul Michael
    Adare
    Carrickbrennan Road
    IRISH Monkstown
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Adare
    Carrickbrennan Road
    IRISH Monkstown
    County Dublin
    Ireland
    British43460730001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish114320980001
    GAVIN, Moira
    15 Eaton Square
    SW1W 9DD London
    Administrateur
    15 Eaton Square
    SW1W 9DD London
    American94611370002
    GLEDHILL, Hugh Thomas Orlando
    Aston Grange Aston
    ST15 0BJ Stone
    Staffordshire
    Administrateur
    Aston Grange Aston
    ST15 0BJ Stone
    Staffordshire
    United KingdomBritish29524300001
    GOULANDRIS, Peter John
    Sea Saga,Edgewater Drive
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Administrateur
    Sea Saga,Edgewater Drive
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    BahamasBahamian62854330004
    GUILLAUMIN, Denis
    35 Princes Gate Court
    SW7 2QJ London
    Administrateur
    35 Princes Gate Court
    SW7 2QJ London
    French55923040002
    HAIG, Gavin
    44 Marsh Lane
    CW5 5LH Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    44 Marsh Lane
    CW5 5LH Nantwich
    Cheshire
    British68733980001
    HARPER, Timothy Wallace
    Hillcroft
    Stoney Lane, Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Hillcroft
    Stoney Lane, Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    British68733880002
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    JENNER, Edward
    Moorside 6 Pipers Lane
    Lower Heswell
    L60 9HP Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Moorside 6 Pipers Lane
    Lower Heswell
    L60 9HP Wirral
    Merseyside
    British41630860001
    JOHNSON, Christopher John Staley
    Kibblestone House
    Oulton Heath
    ST15 8US Stone
    Staffordshire
    Administrateur
    Kibblestone House
    Oulton Heath
    ST15 8US Stone
    Staffordshire
    British8248530001
    JOHNSON, Robert Lewis
    The Old Smithy Gorsey Bank
    Standon
    ST21 6RB Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    The Old Smithy Gorsey Bank
    Standon
    ST21 6RB Stafford
    Staffordshire
    British8248540001
    LITTLE, Roger Forsyth
    Dayhills House
    ST15 7RU Stone
    Staffordshire
    Administrateur
    Dayhills House
    ST15 7RU Stone
    Staffordshire
    Australian117682010001
    MCGILLIVARY, Christopher John
    3864 West Gulf Drive
    Sanibel Island
    Florida
    33957
    United States
    Administrateur
    3864 West Gulf Drive
    Sanibel Island
    Florida
    33957
    United States
    American117682040001
    MCGORAN, Kevin Columba
    Longwood
    7 Herbert Park
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Administrateur
    Longwood
    7 Herbert Park
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    IrelandIrish15442070001
    NIEHAUS, Robert Henry
    105 Evergreen Avenue
    Rye New York 10580
    FOREIGN United States Of America
    Administrateur
    105 Evergreen Avenue
    Rye New York 10580
    FOREIGN United States Of America
    American46823720002
    NUTBEEN, Wayne Jonathan
    The Kent
    Highgrove House Ancoates Lane
    SK9 7TT Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    The Kent
    Highgrove House Ancoates Lane
    SK9 7TT Alderley Edge
    Cheshire
    British63586300004
    O'DONOGHUE, Patrick Redmond
    Cranmore
    Ballinakill Court Dunmore Road
    Waterford Ireland
    Administrateur
    Cranmore
    Ballinakill Court Dunmore Road
    Waterford Ireland
    Irish77402680001
    O'HAGAN, Leonard John Patrick
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Irish15365240001
    O'REILLY, Anthony John Francis
    Castlemartin
    Kilcullen
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Administrateur
    Castlemartin
    Kilcullen
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish46823690001
    O'REILLY, Chryssanthie Jane
    Lissadell
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Administrateur
    Lissadell
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Greek39590670001
    PATTERSON, Brian David
    8 Trentham Court
    Park Drive Trentham
    ST4 8FB Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    8 Trentham Court
    Park Drive Trentham
    ST4 8FB Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Irish50417460001
    RITCHIE, Robin James
    106 Rodenhurst Road
    SW4 8AP London
    Administrateur
    106 Rodenhurst Road
    SW4 8AP London
    EnglandBritish29524320001
    SMITH, Andrew
    5 Brendon Way
    LE65 1EY Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Administrateur
    5 Brendon Way
    LE65 1EY Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British60416710002
    STONIER, George
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish8248550001
    WEDGWOOD, Francis Alan
    Barton House
    Pooley Bridge
    CA10 2NG Penrith
    Cumbria
    Administrateur
    Barton House
    Pooley Bridge
    CA10 2NG Penrith
    Cumbria
    British29524330002
    WEDGWOOD, Piers Anthony Weymouth, Lord
    152
    Ashley Gardens
    SW1 London
    Administrateur
    152
    Ashley Gardens
    SW1 London
    British56478560002

    WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 15 août 2008
    Livré le 23 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £157,017.90 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its interest in the deposit being £157,017.90 plus other monies see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Daejan Investments Limited
    Transactions
    • 23 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of debenture
    Créé le 20 déc. 2005
    Livré le 05 janv. 2006
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America N.A. (The Security Trustee)
    Transactions
    • 05 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Securities pledge agreement
    Créé le 20 déc. 2005
    Livré le 05 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the other creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The securities described in schedule 1.2(a) of the securities pledge agreement (being 363 class b shares in certificate number b-6 of waterford wedgwood canada inc.(the securities)) and any cash dividends options warrants securities instruments or other monies intangibles proceeds or other property received or declared in respect of the securities and all other rights and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A.
    Transactions
    • 05 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of accession to a debenture dated 30 september 2004
    Créé le 03 mars 2005
    Livré le 10 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All group shares and related rights present or future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wachovia Bank, National Association (The Security Trustee)
    Transactions
    • 10 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 2004
    Livré le 07 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 07 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An intercreditor and security trust agreement
    Créé le 26 nov. 2003
    Livré le 17 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to a senior creditor or to an hyb creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    If the company receives from a third party a payment or distribution which should have been paid to the security trustee or a creditor the company must promptly pay to the security trustee the amount received by it and required to be prepaid any amount so received by the company from the third party shall be held by it on trust until such payment is made any amount so received by the security trustee will be applied against the debt in the order provided for under the intercreditor. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security over shares
    Créé le 26 nov. 2003
    Livré le 11 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares, all other shares in the capital of the canadian subsidiary, and all warrants options or pther rights to acquire such shares, all securities instruments negotiable documents of title and other personal property of any kind. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security over shares agreement
    Créé le 26 nov. 2003
    Livré le 09 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first fixed charge all the shares and by way of a first fixed charge all the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 09 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over a bank account
    Créé le 26 nov. 2003
    Livré le 09 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all of its right title and interest in the accounts (being euro accounts nos. 52711170 and 31706620) and the account balances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 09 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 26 nov. 2003
    Livré le 09 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The debtor grants to the secured party for the benefit of the creditors a continuing security interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Secured Party)
    Transactions
    • 09 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 26 nov. 2003
    Livré le 09 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge
    Créé le 28 févr. 1994
    Livré le 15 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of each of the finance documents and the existing facilities (as defined)
    Brèves mentions
    (I) the shares and all dividends and (ii) all stocks, shares and other securities owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental guarantee and debenture
    Créé le 28 févr. 1994
    Livré le 09 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) under the terms of the finance documents and existing facilities defined therein
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 01 mai 1991
    Livré le 03 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the existing facilities or the refinancing agreement of over date.
    Brèves mentions
    (See 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 01 mai 1991
    Livré le 03 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under te terms of the refinancing agreement of even date & the indebtedness agreements.
    Brèves mentions
    (See 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 01 mai 1991
    Livré le 02 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to national westminster bank PLC as agent and trustee for itself and for ech bank (as defined) under the terms of the finance documents and existing facilities defined therein.
    Brèves mentions
    (Please see doc for details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 21 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 mai 2011Administration ended
    05 janv. 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Angus Matthew Martin
    Abbots House Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    practitioner
    Abbots House Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    practitioner
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Nicholas James Dargan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    practitioner
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    2
    DateType
    21 mai 2017Due to be dissolved on
    10 mai 2011Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Angus Matthew Martin
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0