NOTNEEDED NO. 145 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNOTNEEDED NO. 145 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02062791
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NOTNEEDED NO. 145 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NOTNEEDED NO. 145 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NOTNEEDED NO. 145 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MILL GARAGES (NORTHEAST) LIMITED07 avr. 198707 avr. 1987
    SAFESTONE LIMITED09 oct. 198609 oct. 1986

    Quels sont les derniers comptes de NOTNEEDED NO. 145 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour NOTNEEDED NO. 145 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    5 pagesAA

    Nomination de Miss Farheen Ahmad en tant qu'administrateur le 14 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Andrew Dale en tant que directeur le 29 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Thomas Andrew Dale en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anton Clive Jeary en tant que directeur le 04 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    Modification des détails de Mill Garages Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2018

    5 pagesPSC05

    Modification des coordonnées du secrétaire Inchcape Uk Corporate Management Limited le 01 avr. 2018

    3 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT à First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN le 06 avr. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 oct. 2015

    État du capital au 27 oct. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 oct. 2014

    État du capital au 30 oct. 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 nov. 2013

    État du capital au 06 nov. 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de NOTNEEDED NO. 145 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    Secrétaire
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5200589
    100307260072
    AHMAD, Farheen
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritishHead Of Legal266847010001
    INCHCAPE CORPORATE SERVICES LIMITED
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    England
    Administrateur
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement1235709
    133697450001
    BEACHAM, Mark Derrick
    Austwick Lane
    Emerson Valley
    MK4 2DR Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Austwick Lane
    Emerson Valley
    MK4 2DR Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British135313320001
    ANDERSON, John Norman
    7 St Martins Close
    NE26 3JN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    7 St Martins Close
    NE26 3JN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishManaging Director13052050001
    DALE, Thomas Andrew
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United KingdomBritishCompany Director260286850001
    JEARY, Anton Clive
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritishAccountant169892630001
    MCCORMACK, Connor
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    Administrateur
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director108832810002
    PALMER, Richard Terence
    Littlethorpe
    Cleeve Road
    RG8 9BJ Goring
    Administrateur
    Littlethorpe
    Cleeve Road
    RG8 9BJ Goring
    EnglandBritishChief Executive16571890002
    SNAITH, Malcolm
    6 Corbiere Close
    Northfield Green
    SR3 2SP Sunderland
    Tyne And Wear
    Administrateur
    6 Corbiere Close
    Northfield Green
    SR3 2SP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishFinance Director47681530001
    WHEATLEY, Martin Peter
    Amberley Lambridge Wood Road
    RG9 3BS Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Amberley Lambridge Wood Road
    RG9 3BS Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Secretary55180460001
    WILSON, Ann Chrisette
    The Kingswood Ridgemount Road
    SL5 9RW Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    The Kingswood Ridgemount Road
    SL5 9RW Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director14811650002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NOTNEEDED NO. 145 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mill Garages Limited
    Park Square Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Park Square Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom (England) Companies House
    Numéro d'enregistrement2096979
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NOTNEEDED NO. 145 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 31 juil. 1987
    Livré le 13 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 juil. 1987
    Livré le 15 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Leasehold land and premises newcastle road sunderland leasehold land and premises at ryhope road, sunderland.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 15 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 juin 1987
    Livré le 12 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juin 1987Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mai 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All monies which may from time to time be owing to mill garages (north east) by bml (GB) limited (please see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bawmaker Limited
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All monies from time to time owing to the company by V.A.G.(united kingdom) limited.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 avr. 1987
    Livré le 07 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All f/h & l/h property of the company with present & future. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC.
    Transactions
    • 07 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0