STHREE STAFFING UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTHREE STAFFING UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02071875
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STHREE STAFFING UK LIMITED ?

    • Activités des agences de travail temporaire (78200) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe STHREE STAFFING UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STHREE STAFFING UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COMPUTER FUTURES SOLUTIONS LIMITED24 juin 200224 juin 2002
    COMPUTER FUTURES RECRUITMENT CONSULTANTS LIMITED28 nov. 200128 nov. 2001
    COMPUTER FUTURES SOLUTIONS LIMITED27 nov. 200127 nov. 2001
    COMPUTER FUTURES RECRUITMENT CONSULTANTS LIMITED07 nov. 198607 nov. 1986

    Quels sont les derniers comptes de STHREE STAFFING UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour STHREE STAFFING UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 août 2017

    12 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    10 pagesLIQ10

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 8th Floor City Place House 55 Basinghall Street London EC2V 5DX

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor 75 King William Street London EC4N 7BE à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 09 sept. 2016

    2 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 août 2016

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juil. 2016

    État du capital au 05 juil. 2016

    • Capital: GBP 1,070.47
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 juil. 2015

    État du capital au 13 juil. 2015

    • Capital: GBP 1,070.47
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2014

    21 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cavendish Directors Limited le 27 oct. 2014

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Cavendish Directors Limited le 27 oct. 2014

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de 5Th Floor Gps House, 215-227, Great Portland Street, London W1W 5PN à 1St Floor 75 King William Street London EC4N 7BE le 27 oct. 2014

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Anderson le 13 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2014

    État du capital au 14 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,070.47
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Facility agreement 22/05/2014
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 avr. 2014

    État du capital après une attribution d'actions au 22 avr. 2014

    SH01

    Comptes annuels établis au 01 déc. 2013

    22 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Anderson le 02 déc. 2013

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de STHREE STAFFING UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAVENDISH DIRECTORS LIMITED
    75 King William Street
    EC4N 7BE London
    1st Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    75 King William Street
    EC4N 7BE London
    1st Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4326888
    150690900001
    ANDERSON, Sarah
    House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill
    Administrateur
    House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill
    United KingdomBritishDeputy Company Secretary129640450002
    CAVENDISH DIRECTORS LIMITED
    75 King William Street
    EC4N 7BE London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    75 King William Street
    EC4N 7BE London
    1st Floor
    United Kingdom
    94268710003
    BOTTRIELL, William Frederick
    Falcon House
    36 Parkside Wimbledon
    SW19 5NB London
    Secrétaire
    Falcon House
    36 Parkside Wimbledon
    SW19 5NB London
    British67882150001
    CAVENDISH SERVICES LIMITED
    41-44 Great Windmill Street
    W1D 7NB London
    Secrétaire
    41-44 Great Windmill Street
    W1D 7NB London
    79688740003
    ARBER, Simon Peter
    North Sydmonton House
    North Sydmonton
    RG20 4UL Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    North Sydmonton House
    North Sydmonton
    RG20 4UL Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director16876070008
    ARBER, Simon Peter
    North Sydmonton House
    North Sydmonton
    RG20 4UL Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    North Sydmonton House
    North Sydmonton
    RG20 4UL Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishComputer Consultant16876070008
    BOTTRIELL, William Frederick
    Falcon House
    36 Parkside Wimbledon
    SW19 5NB London
    Administrateur
    Falcon House
    36 Parkside Wimbledon
    SW19 5NB London
    EnglandBritishComputer Consultant67882150001
    CLEMENTS, Russell John
    127 Crouch Hill
    N8 9QN London
    Administrateur
    127 Crouch Hill
    N8 9QN London
    United KingdomBritishSales Director41002020006
    COLLETTS, Ian Michael
    23 Purcells Avenue
    HA8 8DP Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    23 Purcells Avenue
    HA8 8DP Edgware
    Middlesex
    United KingdomBritishFinance Director64102680001
    FUELLBERG, Andrik Johannes
    14 Burstock Road
    Putney
    SW15 2PW London
    Administrateur
    14 Burstock Road
    Putney
    SW15 2PW London
    BritishFinancial Controller120302400001
    GOLDSMITH, Gary Christopher
    7a Oldbury Place
    Marylebone
    W1U 5PG London
    Administrateur
    7a Oldbury Place
    Marylebone
    W1U 5PG London
    United KingdomBritishCompany Director69189460002
    HOUTMAN, Richard
    7 Hazelgrove
    Winterbourne
    BS36 1SH Bristol
    Administrateur
    7 Hazelgrove
    Winterbourne
    BS36 1SH Bristol
    United KingdomBritishManaging Director118176050001
    NELSON, Michael John
    5 Egliston Road
    Putney
    SW15 1AL London
    Administrateur
    5 Egliston Road
    Putney
    SW15 1AL London
    BritishCompany Director86398420001
    WICKREMERATNE, Sunil
    40 Mount Park Road
    W5 2RS London
    Administrateur
    40 Mount Park Road
    W5 2RS London
    United KingdomBritishCompany Director50673740002

    STHREE STAFFING UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed & floating charge
    Créé le 25 févr. 2008
    Livré le 29 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 29 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2006
    Livré le 19 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 10 nov. 2005
    Livré le 29 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Créé le 19 avr. 1999
    Livré le 27 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts and any agreement made in variation of, supplemental to, or substitution for such agreement or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement including the related rights which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account by way of floating charge such monies as the company may receive in respect of the debts as shall from time to time stand released from the fixed charge created thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 10 déc. 1997
    Livré le 17 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    £90,000 and all interest.
    Personnes ayant droit
    • The Jaegar Company's Shops Limited
    Transactions
    • 17 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge on debts and related rights
    Créé le 18 oct. 1996
    Livré le 01 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the agreement (as defined) or otherwise
    Brèves mentions
    All debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 01 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 04 juil. 1995
    Livré le 13 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The liabilities of the company to the chargee as detailed in the deed
    Brèves mentions
    The deposit account containing £47,329.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for the Environment
    Transactions
    • 13 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Single debenture
    Créé le 27 févr. 1995
    Livré le 06 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    STHREE STAFFING UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 août 2016Commencement of winding up
    24 févr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0