HOPPANSTOPPER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOPPANSTOPPER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02077085
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOPPANSTOPPER LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HOPPANSTOPPER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HOPPANSTOPPER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAMBERMARSH LIMITED25 nov. 198625 nov. 1986

    Quels sont les derniers comptes de HOPPANSTOPPER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour HOPPANSTOPPER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP le 14 sept. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 sept. 2012

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Richard Anthony Bowler en tant que directeur le 28 août 2012

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 26 mai 2012

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 janv. 2012

    État du capital au 03 janv. 2012

    • Capital: GBP 94,444
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Nomination de Kenneth Mcintyre Carlaw en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Turner en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Alan Severn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan William Severn le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan William Severn le 05 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Paul Turner le 05 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Anthony Bowler le 05 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 05 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HOPPANSTOPPER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Administrateur
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritishCompany Secretary161250030001
    CUMMING, Graham Jackson
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    Secrétaire
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    British22410440002
    SEVERN, Alan William
    Chudleigh House
    High Street
    NN14 4BD Little Addington
    Kettering
    Secrétaire
    Chudleigh House
    High Street
    NN14 4BD Little Addington
    Kettering
    British26710920004
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Secrétaire
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    VIRTUE, John
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British102404840001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director35116070001
    COLLINS, Peter
    16 Princes Place
    Knights Field
    LU2 7LN Luton
    Administrateur
    16 Princes Place
    Knights Field
    LU2 7LN Luton
    BritishCompany Director34631850001
    CUMMING, Graham Jackson
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    Administrateur
    Tudor House 19 Ashpole Furlong
    Loughton
    MK5 8EA Milton Keynes
    BritishCompany Director22410440002
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director77984700001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Administrateur
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector6874440001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    SEVERN, Alan William
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director26710920006
    TURNER, David Paul
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishChartered Secretary48937720001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Administrateur
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    BritishCompany Director2719600006

    HOPPANSTOPPER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Créé le 15 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Brèves mentions
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 11 août 1994
    Livré le 26 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any other security documents (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transactions
    • 26 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 oct. 1990
    Livré le 22 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 12 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 oct. 1990
    Livré le 19 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transactions
    • 19 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 12 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1989
    Livré le 30 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The bus garage stoke road, slough berkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Giro Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1989
    Livré le 30 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The bus garage two waters road, hemel hempstead, herts HP3 9AA.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Giro Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1989
    Livré le 30 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The bus garage 934-974 st albans road garston loatford herts LOD2 6NN. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Giro Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 janv. 1988
    Livré le 07 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee pursuant to clause 6(f) of a share purchase agreement dated 05/01/88
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Bus Company
    Transactions
    • 07 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 05 janv. 1988
    Livré le 19 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee pursuant to clause 6(f) of a share purchase agreement dated 05/01/88
    Brèves mentions
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Bus Company
    Transactions
    • 19 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    A registered charge
    Créé le 05 janv. 1988
    Livré le 11 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stocks shares bonds and securities (see form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transactions
    • 11 janv. 1988Enregistrement d'une charge

    HOPPANSTOPPER LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 avr. 2013Dissolved on
    04 sept. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    practitioner
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    practitioner
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0