HOPPANSTOPPER LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | HOPPANSTOPPER LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02077085 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HOPPANSTOPPER LIMITED ?
Adresse du siège social | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HOPPANSTOPPER LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour HOPPANSTOPPER LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP le 14 sept. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Anthony Bowler en tant que directeur le 28 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 26 mai 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Kenneth Mcintyre Carlaw en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Turner en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Severn en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alan William Severn le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alan William Severn le 05 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Paul Turner le 05 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Anthony Bowler le 05 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 05 janv. 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HOPPANSTOPPER LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIES, Elizabeth Anne | Secrétaire | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
CARLAW, Kenneth Mcintyre | Administrateur | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village | England | British | Company Secretary | 161250030001 | ||||
CUMMING, Graham Jackson | Secrétaire | Tudor House 19 Ashpole Furlong Loughton MK5 8EA Milton Keynes | British | 22410440002 | ||||||
SEVERN, Alan William | Secrétaire | Chudleigh House High Street NN14 4BD Little Addington Kettering | British | 26710920004 | ||||||
THORPE, Elizabeth Anne | Secrétaire | 2 Oakwood DH7 0NP Lanchester County Durham | British | 102907000001 | ||||||
TURNER, David Paul | Secrétaire | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
VIRTUE, John | Secrétaire | 91 Hollywood Avenue Gosforth NE3 5BU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 102404840001 | ||||||
BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Secrétaire | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
BAYFIELD, Stephen | Administrateur | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | Company Director | 42058550001 | |||||
BOWLER, Richard Anthony | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | Company Director | 35116070001 | ||||
COLLINS, Peter | Administrateur | 16 Princes Place Knights Field LU2 7LN Luton | British | Company Director | 34631850001 | |||||
CUMMING, Graham Jackson | Administrateur | Tudor House 19 Ashpole Furlong Loughton MK5 8EA Milton Keynes | British | Company Director | 22410440002 | |||||
JONES, Michael Adrian | Administrateur | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Company Director | 77984700001 | ||||
LONSDALE, Stephen Philip | Administrateur | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4971910001 | ||||
MARTIN, David Robert | Administrateur | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 6874440001 | ||||
RAY, John Alfred | Administrateur | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | Company Director | 58415290001 | |||||
SEVERN, Alan William | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | Company Director | 26710920006 | ||||
TURNER, David Paul | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford Int Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 48937720001 | ||||
WATT, Gordon George | Administrateur | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | England | British | Company Director | 67622780002 | ||||
WILLIAMS, Dawson Thomas | Administrateur | Chately Wood House Rockford BH24 3LZ Ringwood Hampshire | British | Company Director | 2719600006 |
HOPPANSTOPPER LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Letter of charge and set-off over credit balances | Créé le 15 août 1994 Livré le 31 août 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994 | |
Brèves mentions All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 11 août 1994 Livré le 26 août 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any other security documents (as defined in the charge) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 12 oct. 1990 Livré le 22 oct. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 12 oct. 1990 Livré le 19 oct. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 25 août 1989 Livré le 30 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The bus garage stoke road, slough berkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 25 août 1989 Livré le 30 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The bus garage two waters road, hemel hempstead, herts HP3 9AA.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 25 août 1989 Livré le 30 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The bus garage 934-974 st albans road garston loatford herts LOD2 6NN. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 janv. 1988 Livré le 07 janv. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from thecompany to the chargee pursuant to clause 6(f) of a share purchase agreement dated 05/01/88 | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 janv. 1988 Livré le 19 janv. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from thecompany to the chargee pursuant to clause 6(f) of a share purchase agreement dated 05/01/88 | |
Brèves mentions (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 05 janv. 1988 Livré le 11 janv. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Stocks shares bonds and securities (see form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
HOPPANSTOPPER LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0