INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED

INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02080759
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O TENEO FINANCIAL ADVISORY LIMITED
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE PUBLIC LIMITED COMPANY04 déc. 198604 déc. 1986

    Quels sont les derniers comptes de INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le28 févr. 2020
    Date d'échéance des prochains comptes28 févr. 2021
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2019

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au05 déc. 2021
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation19 déc. 2021
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au05 déc. 2020
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 oct. 2024

    21 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    12 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    11 pagesLIQ10

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    21 pagesAM22

    Changement d'adresse du siège social de C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN à The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT le 20 mai 2023

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Changement d'adresse du siège social de C/O Teneo Restructuring 156 Great Charles Street Queensway Birmingham B3 3HN à C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN le 14 sept. 2022

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    31 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    13 pagesAM02

    Résultat de la réunion des créanciers

    73 pagesAM07

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    71 pagesAM03

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Changement d'adresse du siège social de 85 Great Portland Street 1st Floor London W1W 7LT England à C/O Teneo Restructuring 156 Great Charles Street Queensway Birmingham B3 3HN le 01 nov. 2021

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 55-58 Pall Mall London SW1Y 5JH England à 85 Great Portland Street 1st Floor London W1W 7LT le 08 juin 2021

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 05 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Glossop en tant que directeur le 30 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 14th Floor, Portland House Bressenden Place London SW1E 5BH England à 55-58 Pall Mall London SW1Y 5JH le 18 mars 2020

    1 pagesAD01

    Comptes consolidés établis au 28 févr. 2019

    48 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 14th Floor Portland House Cardinal Place London SW1E 5RS à 14th Floor, Portland House Bressenden Place London SW1E 5BH le 04 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 19-21 Shaftesbury Avenue London W1D 7ED à 14th Floor Portland House Cardinal Place London SW1E 5RS le 15 mars 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 05 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VALLANCE, James Michael Alexander
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    Secrétaire
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    200789830001
    SARKARI, Kurush Phiroze
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    Administrateur
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    EnglandBritishDirector114732120001
    TEJANI, Firozali Gulamali
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    Administrateur
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    United KingdomBritishDirector2434060003
    TEJANI, Hassanali Gulamali
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    Administrateur
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    United KingdomBritishCompany Director96469670002
    TEJANI, Nizarali Gulamali
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    Administrateur
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    CanadaBritishCompany Director2434090028
    TEJANI, Zulfikarally Gulamali
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    Administrateur
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    United KingdomBritishCompany Director71737620002
    VALLANCE, James Michael Alexander
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    Administrateur
    20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building
    EnglandBritishDirector119802950001
    JOHNSON, Trevor Eric
    Knightstone
    2 Fosseway
    WS14 0AD Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    Knightstone
    2 Fosseway
    WS14 0AD Lichfield
    Staffordshire
    British5487610001
    MCDONALD, Michael John
    60 Varsity Drive
    TW1 1AH Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    60 Varsity Drive
    TW1 1AH Twickenham
    Middlesex
    IrishAccountant74228800001
    MILES, Alan
    163a Earls Court Road
    SW5 9RF London
    Secrétaire
    163a Earls Court Road
    SW5 9RF London
    British23004180001
    WHITE, Adrian Philip
    Shaftesbury Avenue
    W1D 7ED London
    19-21
    Secrétaire
    Shaftesbury Avenue
    W1D 7ED London
    19-21
    British101912930001
    COLLIER, Richard John
    Lingfields
    Whempstead Road
    SG2 7BX Benington
    Hertfordshire
    Administrateur
    Lingfields
    Whempstead Road
    SG2 7BX Benington
    Hertfordshire
    BritishCompany Director84696900002
    FRASER, Stephen Clive
    62 Fourth Cross Road
    TW2 5EP Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    62 Fourth Cross Road
    TW2 5EP Twickenham
    Middlesex
    BritishBanker36620870001
    GLOSSOP, Paul
    Pall Mall
    SW1Y 5JH London
    55-58
    England
    Administrateur
    Pall Mall
    SW1Y 5JH London
    55-58
    England
    EnglandBritishDirector Retail Development122934690001
    JOHNSON, Trevor Eric
    Albany Court Yard
    47-48 Piccadilly
    W1J 0LR London
    Administrateur
    Albany Court Yard
    47-48 Piccadilly
    W1J 0LR London
    United KingdomBritishBanker5487610001
    MILES, Alan
    163a Earls Court Road
    SW5 9RF London
    Administrateur
    163a Earls Court Road
    SW5 9RF London
    BritishBanker23004180001
    RAJAN, Amin Haji
    2 Holly Hill Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    2 Holly Hill Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishEconomist22055720002
    THATHIAH, Kreeson
    Albany Court Yard
    47-48 Piccadilly
    W1J 0LR London
    Administrateur
    Albany Court Yard
    47-48 Piccadilly
    W1J 0LR London
    EnglandBritishDirector162123080002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lenlyn Holdings Limit
    Shaftesbury Avenue
    W1D 7ED London
    19-21
    England
    06 avr. 2016
    Shaftesbury Avenue
    W1D 7ED London
    19-21
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 19 déc. 2014
    Livré le 08 janv. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Firozali Gulamali Tejani
    Transactions
    • 08 janv. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 19 déc. 2014
    Livré le 24 déc. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hassanali Gulamali Dharamshi Tejani
    Transactions
    • 24 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 19 déc. 2014
    Livré le 24 déc. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nizarali Tejani
    Transactions
    • 24 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 19 déc. 2014
    Livré le 24 déc. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Zulfikarally Tejani
    Transactions
    • 24 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 juin 2006
    Livré le 20 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 13 sept. 2004
    Livré le 17 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ncr personas 84 s/n 35831915, ncr personas 84 s/n 35831916, ncr personas 84 s/n 35831919 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 17 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 févr. 2004
    Livré le 09 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the trustees on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Lenlyn UK Limited Executive Pension Scheme
    Transactions
    • 09 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus letter of set-off
    Créé le 15 mai 2003
    Livré le 24 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of policy
    Créé le 03 nov. 1994
    Livré le 18 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bankers blanket bond policy number 551/43L7335 dated 16 april 1993 between the company and royal insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of policy
    Créé le 29 oct. 1993
    Livré le 01 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    General money infill policy number 551/43L7336 and all the monies assured or to become payable under or by virtue of such policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of policy
    Créé le 06 oct. 1993
    Livré le 22 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Bankers blanket bond policy number 551/43L7335 dated 16TH april 1993. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Single debenture
    Créé le 17 août 1993
    Livré le 03 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of security
    Créé le 05 juin 1992
    Livré le 17 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All amounts....standing to the credit of the co's account no. 309-026037234.... see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Banque Bruxelles Lambert S.A.
    Transactions
    • 17 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 08 mars 1990
    Livré le 12 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a county house, surrey street bristol t/nos:- bl 33641 av 13623 av 38 av 760 bl 4352 av 22029 with all buildings & fixtures assignment of the goodwill of the business (if any) carried on by the mortgagor at the mortgated premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 12 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 26 nov. 1987
    Livré le 10 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stock in trade work in progress. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Banque Bruxelles Lambert S.A.
    Transactions
    • 10 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 23 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 oct. 2021Administration started
    14 oct. 2023Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Michael Hawes
    156 Great Charles Street Queensway
    B3 3HN Birmingham
    practitioner
    156 Great Charles Street Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Adrian Peter Berry
    156 Great Charles Street Queensway
    B3 3HN Birmingham
    practitioner
    156 Great Charles Street Queensway
    B3 3HN Birmingham
    2
    DateType
    14 oct. 2023Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul James Meadows
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    practitioner
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Richard Michael Hawes
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    practitioner
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Adrian Peter Berry
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    West Midlands
    practitioner
    The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    West Midlands

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0