AAF PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAAF PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02080946
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AAF PROPERTIES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe AAF PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Catfoss Lane
    Brandesburton
    YO25 8EJ Driffield
    East Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AAF PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AAF INDUSTRIES LIMITED21 févr. 199221 févr. 1992
    ANGLO AFRICAN FINANCE LIMITED15 mai 198715 mai 1987
    AAF INVESTMENT CORPORATION LIMITED02 févr. 198702 févr. 1987
    TAVISHILL LIMITED05 déc. 198605 déc. 1986

    Quels sont les derniers comptes de AAF PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour AAF PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Craig Glover en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Aaf Consultants Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 sept. 2010

    État du capital au 17 sept. 2010

    • Capital: GBP 1,263,926
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Aaf Consultants Limited le 31 août 2010

    2 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Aaf Consultants Limited le 11 févr. 2010

    1 pagesCH04

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes établis au 30 juin 2008

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 juin 2007

    8 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 30 juin 2006

    8 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    10 pages155(6)b

    legacy

    10 pages155(6)a

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re-fac agr com int 16/02/06
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    Statuts

    12 pagesMA

    Qui sont les dirigeants de AAF PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GLOVER, Craig
    Catfoss Lane
    Brandesburton
    YO25 8EJ Driffield
    East Yorkshire
    Secrétaire
    Catfoss Lane
    Brandesburton
    YO25 8EJ Driffield
    East Yorkshire
    157401110001
    DE SA, Eugenio Pereira Carneiro
    4 Hambling Drive
    HU17 9GD Beverley
    East Yorkshire
    Administrateur
    4 Hambling Drive
    HU17 9GD Beverley
    East Yorkshire
    United KingdomPortuguese69998030002
    DYNE, Susan Dana
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    Secrétaire
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    British17486540001
    HERSCH, Benson Selwyn
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    60 Grange Gardens
    HA5 5QF Pinner
    Middlesex
    British6057020001
    AAF CONSULTANTS LIMITED
    Catfoss Lane
    Brandesburton
    YO25 8EJ Driffield
    Catfoss Airfield
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Catfoss Lane
    Brandesburton
    YO25 8EJ Driffield
    Catfoss Airfield
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2487565
    39707280002
    DYNE, Ronald Irvin
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    Administrateur
    6 Marsh Close
    Mill Hill
    NW7 4NY London
    British10505810001
    EDMUND, Steven
    Carr Lodge
    14 Carr Lane
    HU17 9SD Tickton
    North Humberside
    Administrateur
    Carr Lodge
    14 Carr Lane
    HU17 9SD Tickton
    North Humberside
    EnglandSouth African76331050002
    HASTIE, Roger
    The Chestnuts
    2 Redebourne Lane Bury
    PE26 2PB Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    The Chestnuts
    2 Redebourne Lane Bury
    PE26 2PB Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomScottish78715280001
    KRUMHOLECTSKI, Riaan
    25 Fourth Avenue
    Westdene
    FOREIGN Johannesburg
    Gauteng 2006
    South Africa
    Administrateur
    25 Fourth Avenue
    Westdene
    FOREIGN Johannesburg
    Gauteng 2006
    South Africa
    South African68889510001
    SCHLOSBERG, Hilton Hiller
    2 Lake Drive
    Hartsbourne Road
    WD2 1QP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Lake Drive
    Hartsbourne Road
    WD2 1QP Bushey Heath
    Hertfordshire
    South African36217260002
    WALKER, Andrew Lockhart
    59a Main Street
    Hotham
    YO43 4UB York
    Administrateur
    59a Main Street
    Hotham
    YO43 4UB York
    British87925220004
    WHYATT, Stephen John
    9 Lockhart Road
    KT11 2AX Cobham
    Surrey
    Administrateur
    9 Lockhart Road
    KT11 2AX Cobham
    Surrey
    British41664620001
    WORLLEDGE, Peter John Franklin
    Letham Farmhouse
    EH41 4NW Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    Letham Farmhouse
    EH41 4NW Haddington
    East Lothian
    British93839300001

    AAF PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company, each security provider and each transaction party to the chargee or any other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ubs Nominees Pty Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 06 sept. 2004
    Livré le 17 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by each obligor to the secured parties (or any of them)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 janv. 2001
    Livré le 19 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 juil. 1994
    Livré le 29 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north west side of whitebirk drive blackburn lancs tog with all other erections and all fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 juil. 1994
    Livré le 29 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on north west side of whitebirk drive blackburn lancs tog with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contract dees undertaking and warranties and the goodwill of the business.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 nov. 1993
    Livré le 25 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the east side of catwick lane brandesburton humberside. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 févr. 1993
    Livré le 16 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at catwick lane breandesburton driffield north humberside.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 1992
    Livré le 08 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land and buildings on the north west side of whitebirk drive, blackburn, lancashire t/no: la 328865.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 nov. 1992
    Livré le 24 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mai 1992
    Livré le 09 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on north west of whitebirk drive blackburn lancashire title no:LA328865. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 09 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0