GREENBARR LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GREENBARR LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02090236 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GREENBARR LIMITED ?
| Adresse du siège social | Micros Fidelio House 6-8 The Grove SL1 1QP Slough Berkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GREENBARR LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GREENBARR LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour GREENBARR LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010 | 2 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gary Kaufman en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2009 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2008 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2007 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GREENBARR LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALDER, Stephen | Secrétaire | The Old Brew House Brewery Common RG7 3JE Mortimer Berkshire | British | 41833080003 | ||||||
| NIROOMAND, Kaweh | Administrateur | Salzach Strasse 55a FOREIGN 14129 Berlin Germany | Usa | Iranian | 119291160001 | |||||
| WALDER, Stephen | Administrateur | The Old Brew House Brewery Common RG7 3JE Mortimer Berkshire | United Kingdom | British | 41833080003 | |||||
| WARD, Frank Peter | Administrateur | 30 Bridle Road SL6 7RP Maidenhead Berkshire | United Kingdom | Irish | 118809190001 | |||||
| COSTER, Malcolm David | Secrétaire | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | British | 39034110001 | ||||||
| COTTRELL, Paul Alan | Secrétaire | 16 Goldcrest Drive TN22 5QG Uckfield East Sussex | British | 13754300002 | ||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Secrétaire | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||
| GALL, Alan Farquhar | Secrétaire | 4 Wellesley Road TW2 5RS Twickenham Middlesex | British | 1728300001 | ||||||
| TAYLOR, David | Secrétaire | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| BAKER, Carl Howard | Administrateur | The Croft Clews Lane GU24 9DZ Bisley Surrey | British | 58321590001 | ||||||
| BRADLEY, Michael John | Administrateur | Vantage Point 208 Henwick Road WR2 5PF Worcester | British | 40818740003 | ||||||
| COBY, Alan John | Administrateur | Windermere Lodge Friday Street Pebworth CV37 8XW Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 50358320001 | ||||||
| COBY, Helen Mary | Administrateur | The Plantation House Hotel Ermington PL21 9NS Ivybridge Devon | British | 80139540001 | ||||||
| CODGAN, James Raymond | Administrateur | 32 King Edwards Road SL5 8NY Ascot Berkshire | British | 19597140001 | ||||||
| COSTER, Malcolm David | Administrateur | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | England | British | 39034110001 | |||||
| EVANS, Robert Owen | Administrateur | Hollybank 32 Birches Lane CV8 2AD Kenilworth Warwickshire | British | 57011000001 | ||||||
| GRAHAM, Ross King | Administrateur | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||
| KAUFMAN, Gary | Administrateur | 10203 Castehill Court Ellicott Md 21042 Usa | Usa | American | 118968570001 | |||||
| LOMAX, Christopher Morris David | Administrateur | 4 Greenwood Road WA13 0LA Lymm Cheshire | British | 32315330001 | ||||||
| LOMAX, John Kevin | Administrateur | Hawling Manor Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | British | 22190280002 | ||||||
| MATTHEW, Gordon John | Administrateur | Rogers Lane Ettrington CV37 3TA Stratford Upon Avon Saracens Yard Warwickshire | England | British | 151547160001 | |||||
| NORTON, John Laurence | Administrateur | 4 Waveney Close OX6 8GP Bicester Oxfordshire | British | 34339250001 | ||||||
| O'LEARY, Michael Kevin | Administrateur | Greenwood Wichenford WR6 6YB Worcester Worcestershire | England | British | 129193560001 | |||||
| TAYLOR, David | Administrateur | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Administrateur | 1 Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford | England | British | 76932830002 |
GREENBARR LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Credit agreement | Créé le 18 juil. 1991 Livré le 25 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £53,003.16 due from the company to the chargee under the terms of the agreement. | |
Brèves mentions All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Credit agreement | Créé le 13 mars 1991 Livré le 20 mars 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £15949-24 due from the company under the terms of the agreement | |
Brèves mentions All right, title and interest under the insurance. See form 395 (ref 495). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Credit agreement | Créé le 10 mai 1990 Livré le 22 mai 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All its right title and interest in and to all sums payable under the insurances see form 395 (ref 136) for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 12 avr. 1989 Livré le 27 avr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee | |
Brèves mentions All its right, title & interest in & to all sums payable (including by way of refund (under the insurances. As from time time varied or extended & the benfit of all powers & remedies for cancelling and/or enforcing the same. (For full details see form M395-M50C). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 10 mars 1987 Livré le 17 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0