GREENBARR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREENBARR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02090236
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREENBARR LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe GREENBARR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Micros Fidelio House
    6-8 The Grove
    SL1 1QP Slough
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GREENBARR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED27 févr. 198727 févr. 1987
    VISUALANNUAL LIMITED16 janv. 198716 janv. 1987
    INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED16 janv. 198716 janv. 1987

    Quels sont les derniers comptes de GREENBARR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GREENBARR LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour GREENBARR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 déc. 2013

    État du capital au 10 déc. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    2 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Gary Kaufman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2008

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2007

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de GREENBARR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALDER, Stephen
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    Secrétaire
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    British41833080003
    NIROOMAND, Kaweh
    Salzach Strasse 55a
    FOREIGN 14129 Berlin
    Germany
    Administrateur
    Salzach Strasse 55a
    FOREIGN 14129 Berlin
    Germany
    UsaIranian119291160001
    WALDER, Stephen
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    United KingdomBritish41833080003
    WARD, Frank Peter
    30 Bridle Road
    SL6 7RP Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    30 Bridle Road
    SL6 7RP Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomIrish118809190001
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Secrétaire
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    British39034110001
    COTTRELL, Paul Alan
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    Secrétaire
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    British13754300002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GALL, Alan Farquhar
    4 Wellesley Road
    TW2 5RS Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    4 Wellesley Road
    TW2 5RS Twickenham
    Middlesex
    British1728300001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    BAKER, Carl Howard
    The Croft Clews Lane
    GU24 9DZ Bisley
    Surrey
    Administrateur
    The Croft Clews Lane
    GU24 9DZ Bisley
    Surrey
    British58321590001
    BRADLEY, Michael John
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    Administrateur
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    British40818740003
    COBY, Alan John
    Windermere Lodge Friday Street
    Pebworth
    CV37 8XW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Windermere Lodge Friday Street
    Pebworth
    CV37 8XW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British50358320001
    COBY, Helen Mary
    The Plantation House Hotel
    Ermington
    PL21 9NS Ivybridge
    Devon
    Administrateur
    The Plantation House Hotel
    Ermington
    PL21 9NS Ivybridge
    Devon
    British80139540001
    CODGAN, James Raymond
    32 King Edwards Road
    SL5 8NY Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    32 King Edwards Road
    SL5 8NY Ascot
    Berkshire
    British19597140001
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Administrateur
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    EnglandBritish39034110001
    EVANS, Robert Owen
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    KAUFMAN, Gary
    10203 Castehill Court
    Ellicott
    Md 21042
    Usa
    Administrateur
    10203 Castehill Court
    Ellicott
    Md 21042
    Usa
    UsaAmerican118968570001
    LOMAX, Christopher Morris David
    4 Greenwood Road
    WA13 0LA Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    4 Greenwood Road
    WA13 0LA Lymm
    Cheshire
    British32315330001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MATTHEW, Gordon John
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    Administrateur
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    EnglandBritish151547160001
    NORTON, John Laurence
    4 Waveney Close
    OX6 8GP Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    4 Waveney Close
    OX6 8GP Bicester
    Oxfordshire
    British34339250001
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish129193560001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WINGFIELD, Richard Alan
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    Administrateur
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    EnglandBritish76932830002

    GREENBARR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Credit agreement
    Créé le 18 juil. 1991
    Livré le 25 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £53,003.16 due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 25 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 13 mars 1991
    Livré le 20 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £15949-24 due from the company under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All right, title and interest under the insurance. See form 395 (ref 495).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 20 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 10 mai 1990
    Livré le 22 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurances see form 395 (ref 136) for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 22 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 12 avr. 1989
    Livré le 27 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Brèves mentions
    All its right, title & interest in & to all sums payable (including by way of refund (under the insurances. As from time time varied or extended & the benfit of all powers & remedies for cancelling and/or enforcing the same. (For full details see form M395-M50C).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 27 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 10 mars 1987
    Livré le 17 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 07 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0