UCI DEVELOPMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | UCI DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02090653 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe UCI DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de UCI DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour UCI DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX | 2 pages | AD03 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX à 1 More London Place London SE1 2AF le 06 oct. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kirsten Lawton en tant que secrétaire le 18 mai 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Brooks Rainer en tant qu'administrateur le 18 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kirsten Lawton en tant que secrétaire le 18 mai 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil James Williams en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Jonathan Way en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Stephen Alker en tant que directeur le 18 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Michael Donovan en tant que directeur le 30 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Kirsten Lawton le 04 août 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de UCI DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINER, John Brooks | Administrateur | More London Place SE1 2AF London 1 | United States | American | 230136900001 | |||||
| FOX, Carol Collins | Secrétaire | Lee House 90 Greay Bridgewater Street M1 5JW Manchester | British | 34028170003 | ||||||
| JAGANNATH, Vidya | Secrétaire | 4 Caterham Avenue BL3 3RF Bolton Lancashire | British | 104920640001 | ||||||
| LAWTON, Kirsten | Secrétaire | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | British | 50045660003 | ||||||
| MCDONAGH, John James | Secrétaire | 6 Redesmere Close Timperley WA15 7EE Altrincham Cheshire | British | 38769610001 | ||||||
| RIBBONS, Justin Charles | Secrétaire | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| RICHARDS, James Timothy | Secrétaire | 8a Marides Road Kensington W8 2LJ London | British | 30429210001 | ||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| ALKER, Andrew Stephen | Administrateur | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | 120642230001 | |||||
| DONOVAN, Paul Michael | Administrateur | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | England | British | 154988050002 | |||||
| GAVIN, Alexander Rupert | Administrateur | Whitcomb Street WC2H 7DN London 54 | England | British | 16875680005 | |||||
| GOSLING, Steven Paul | Administrateur | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 124301460001 | |||||
| HARRIS, Roger John | Administrateur | Green Villa Park SK9 6EJ Wilmslow 14 Cheshire | United Kingdom | British | 129109390001 | |||||
| HILDRED, Richard John | Administrateur | 3 Beech Hill Mobberley WA16 7HT Cheshire | United Kingdom | British | 112979700001 | |||||
| HILDRED, Richard John | Administrateur | 3 Beech Hill Mobberley WA16 7HT Cheshire | United Kingdom | British | 112979700001 | |||||
| RIBBONS, Justin Charles | Administrateur | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| RIBBONS, Justin Charles | Administrateur | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| SINYOR, Joseph | Administrateur | 70 Sheldon Avenue N6 4ND London | United Kingdom | British | 142528420002 | |||||
| WAY, Mark Jonathan | Administrateur | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | 191239860001 | |||||
| WILLIAMS, Neil James | Administrateur | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 194329360001 | |||||
| ESSENTIAL CINEMAS BV | Administrateur | Amsteldijk 166 1079 Lh Amsterdam Netherlands | 102479600001 | |||||||
| UNITED CINEMAS INTERNATIONAL MULTIPLEX BV | Administrateur | Amsteldijk 166 1079 Lh Amsterdam Netherlands | 102479570001 | |||||||
| UNIVERSAL STUDIOS HOLDING III CORP | Administrateur | 800 Third Avenue New York Ny 10022 Usa | 98626030001 | |||||||
| UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV | Administrateur | Hagedoornlaan 2 PO BOX 37267 FOREIGN Amsterdam 1030 Ag | 30239060004 | |||||||
| VIACOM INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV | Administrateur | Naritaweg 207 1043 Cb Amsterdam The Netherlands | 37696370007 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UCI DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Cinemas International (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
UCI DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security registered in scotland on 28/2/91 | Créé le 28 févr. 1991 Livré le 11 mars 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee terms of a personal bond dated 4TH & 10TH october 1990 | |
Brèves mentions All & whole the tenants part of lease relating to all & whole that area of ground extending 0.640 hectares in the clydesbank district of strathclyde region forming part of phase 111 of the clyde shopping centre, title no dmb 22832. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 01 déc. 1989 Livré le 18 déc. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti Not exceeding £110,000,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of letter of credit, the overdraft facility and any relevant collateral dcoument (as defined) | |
Brèves mentions (See doc M395 ref M263L for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental loan agreement | Créé le 07 nov. 1989 Livré le 22 nov. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti £64,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/12/88 and this deed | |
Brèves mentions Floating charge over (see doc M551C for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental loan agreement | Créé le 14 sept. 1989 Livré le 19 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement dated 12/12/88 and this deed | |
Brèves mentions Floating charge over (see 395-tc no. 213 for further details). Undertaking and all property and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental loan agreement, | Créé le 16 juin 1989 Livré le 03 juil. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti £48,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH december 1988 and this supplemental loan agreement | |
Brèves mentions Floating charge over all the undertaking, property assets and rights (see for 395 relative to this charge ref m 568C for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Loan agreement | Créé le 12 déc. 1988 Livré le 28 déc. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from amc entertainments (UK) limited and/or CIC multiplex cinemas B.V. to the chargee under the terms of the loan agreement | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over all the undertaking, property assets and rights (please refer to doc M395 ref M364 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
UCI DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0