PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED

PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02092780
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Elektron Technology Plc Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NPE-INNOTEK LIMITED07 août 200107 août 2001
    N P E PRECISION TOOLROOM LIMITED30 mai 199630 mai 1996
    NEATH PRECISION ENGINEERING LIMITED03 mars 198703 mars 1987
    HARTONDALE LIMITED23 janv. 198723 janv. 1987

    Quels sont les derniers comptes de PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 26 oct. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cap red reserve reduced 24/10/2012
    RES13

    Nomination de Mr Keith Anthony Daley en tant qu'administrateur le 23 oct. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Noah Felix Kalman Franklin en tant que directeur le 23 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Matthew Chaloner en tant que directeur le 31 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2011

    9 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Elektron Plc Melville Court Spilsby Road Romford Essex RM3 8SB le 02 nov. 2011

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Noah Felix Kalman Franklin en tant qu'administrateur le 31 août 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Geoffrey Spink en tant que directeur le 31 août 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    3 pagesAUD

    Nomination de Mr Geoffrey Spink en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Martin Leslie Reeves en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Christopher Leigh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Leigh en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2010

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REEVES, Martin Leslie
    Gryfe Road
    PA11 3AL Bridge Of Weir
    Glendale
    Renfrewshire
    Scotland
    Secrétaire
    Gryfe Road
    PA11 3AL Bridge Of Weir
    Glendale
    Renfrewshire
    Scotland
    155650560001
    DALEY, Keith Anthony
    Stapleton Hall Road
    N4 4QA London
    76
    United Kingdom
    Administrateur
    Stapleton Hall Road
    N4 4QA London
    76
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector1693740001
    CHALONER, Matthew
    Thornton
    York Lane Langho
    BB6 8EH Blackburn
    Lancashire
    Secrétaire
    Thornton
    York Lane Langho
    BB6 8EH Blackburn
    Lancashire
    British71023320003
    COOK, Michael Phillip
    34 The Highlands
    Neath Abbey
    SA10 6PB Neath
    West Glamorgan
    Secrétaire
    34 The Highlands
    Neath Abbey
    SA10 6PB Neath
    West Glamorgan
    British53362710001
    LAWRENCE, Gerald
    3 Highfield
    Cimla
    SA11 3UA Neath
    Secrétaire
    3 Highfield
    Cimla
    SA11 3UA Neath
    British22796150001
    LEIGH, Christopher Michael
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    BritishChartered Accountant24955980002
    CHALONER, Matthew
    Thornton
    York Lane Langho
    BB6 8EH Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    Thornton
    York Lane Langho
    BB6 8EH Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritishAccountant71023320003
    EDWARDS, Michael
    79 Castle Drive
    Cimla
    SA11 3YF Neath
    West Glamorgan
    Administrateur
    79 Castle Drive
    Cimla
    SA11 3YF Neath
    West Glamorgan
    BritishProduction Director38979840001
    FLETCHER, Christopher
    Wants Green Farm
    Wants Green
    WR6 5NU Broadwas
    Worcestershire
    Administrateur
    Wants Green Farm
    Wants Green
    WR6 5NU Broadwas
    Worcestershire
    BritishDirector107542670001
    FRANKLIN, Noah Felix Kalman
    Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    C/O Elektron Technology Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    Broers Building
    21 J J Thomson Avenue
    CB3 0FA Cambridge
    C/O Elektron Technology Plc
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer53608960001
    GIBSON, John Frederick
    Unit 2
    1 Lancaster Gardens West
    CO15 6QG Clacton On Sea
    Essex
    Administrateur
    Unit 2
    1 Lancaster Gardens West
    CO15 6QG Clacton On Sea
    Essex
    BritishDirector20433310005
    GOVAN, George Russell
    55 Brookfield Road
    Churchdown
    GL3 2PG Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    55 Brookfield Road
    Churchdown
    GL3 2PG Gloucester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector14024420001
    JOHN, Neville
    31 Quarry Road
    Treboeth
    SA5 9DJ Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    31 Quarry Road
    Treboeth
    SA5 9DJ Swansea
    West Glamorgan
    WelshCompany Director22796160001
    LEIGH, Christopher Michael
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Arranmoor 11 Hillwood Close
    Hutton Mount
    CM13 2PE Brentwood
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant24955980002
    SANDFORD, Paul Richard
    The Walled Garden
    Howle Hill
    HR9 5ST Ross On Wye
    Herefordshire
    Administrateur
    The Walled Garden
    Howle Hill
    HR9 5ST Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishDirector12445280001
    SPINK, Geoffrey
    Swan Lane
    GU47 9DN Sandhurst
    5 Lakeside Business Park
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Swan Lane
    GU47 9DN Sandhurst
    5 Lakeside Business Park
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director84940730001
    VEALE, Ann
    58 Glanmor Road
    Uplands
    SA2 0QB Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    58 Glanmor Road
    Uplands
    SA2 0QB Swansea
    West Glamorgan
    BritishCompany Director22796180001
    VEALE, David Paul
    58 Glanmor Road
    Uplands
    SA2 0QB Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    58 Glanmor Road
    Uplands
    SA2 0QB Swansea
    West Glamorgan
    BritishCompany Director54236830001
    VEALE, Peter John
    58 Glanmor Road
    Uplands
    SA2 0QB Swansea
    West Glamorgan
    Administrateur
    58 Glanmor Road
    Uplands
    SA2 0QB Swansea
    West Glamorgan
    BritishCompany Director68796310001

    PHOENIX RISING FROM THE ASHES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Chattels mortgage
    Créé le 24 mai 2006
    Livré le 25 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Charmiles robofil 2030SI wire edm maching centre s/no 124209 them proceeds of all policies of insurance now or in the future and the benefit of all options and rights.
    Personnes ayant droit
    • Hitachi Capital (UK) Limited
    Transactions
    • 25 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture (including qualifying floating charge)
    Créé le 02 sept. 2004
    Livré le 11 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 11 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Debenture
    Créé le 20 nov. 2002
    Livré le 21 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chosen Industries Limited
    Transactions
    • 21 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 nov. 2002
    Livré le 26 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 12 nov. 2002
    Livré le 20 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Shop floor 2 hpc SK19 plusair packaged air compressors hpc ES250 water oil separator hpc TC36 packaged air dryer for details of futher chattels charged please refer to form 395 the plant machinery chattels or other equipment together with any part or parts thereof and all additions alterations accessories replacements and renewals of component parts thereto and together with the benefit of any obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the mortgaged property and all obligations and warranties given by any other party in respect of the mortgaged property and the benefit of all maintenance agreements.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 janv. 2000
    Livré le 19 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 18 mai 1989
    Livré le 22 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 août 1987
    Livré le 07 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £107,618 & all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement d/d 19.6.87
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Metal Box Public Limited Company
    Transactions
    • 07 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0