KERSTONFELL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKERSTONFELL LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 02092785
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KERSTONFELL LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe KERSTONFELL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KERSTONFELL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STUART ROBB FUNERAL SERVICE LIMITED(THE)12 mars 198712 mars 1987
    KERSTONFELL LIMITED23 janv. 198723 janv. 1987

    Quels sont les derniers comptes de KERSTONFELL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KERSTONFELL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour KERSTONFELL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Forms b & z - convert to i&ps
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to i&ps 14/08/2012
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 août 2012

    État du capital au 10 août 2012

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2012

    3 pagesAA

    Nomination de Andrew Oldale en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Walker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Hendry en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Hendry en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr George Murray Tinning le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Buchan Hendry le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil James Walker le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2010

    3 pagesAA

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Katherine Eldridge en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 10 janv. 2009

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 12 janv. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de KERSTONFELL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Secrétaire
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    150154570001
    OLDALE, Andrew
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    Administrateur
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    EnglandBritish167083200001
    TINNING, George Murray
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish126913730001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Secrétaire
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    British10084840001
    BEWLEY, Bernard
    8 Ash Rise
    ST17 9HE Stafford
    Staffordshire
    Secrétaire
    8 Ash Rise
    ST17 9HE Stafford
    Staffordshire
    British2087640001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Secrétaire
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    British84868550001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Secrétaire
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    111685670001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish10084840001
    HENDRY, David Buchan
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    ScotlandBritish128555100001
    HENDRY, David Buchan
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    Administrateur
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    ScotlandBritish128555100001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Administrateur
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    EnglandBritish84868550001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Administrateur
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    THOMSON, John
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    British57103470001
    WALKER, Neil James
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th Floor, New Century House
    United Kingdom
    EnglandBritish126913860001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Administrateur
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    110868260001

    KERSTONFELL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 12 août 1987
    Livré le 19 août 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 06 juil. 1987
    Livré le 20 juil. 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 60 the hill sandbach cheshire and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 06 juil. 1987
    Livré le 20 juil. 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a "laburnam cottage" 17 macclesfield road, holmes, chapel cheshire and the proceeds of sale thereof of together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1987
    Livré le 22 juin 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a plot of land adjoining antrobus street, congleton cheshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1987
    Livré le 22 juin 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    12 hospital street, crewe and nantwich cheshire T.N. ch 235614 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1987
    Livré le 22 juin 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 93 antrobus street, congleton, cheshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1987
    Livré le 22 juin 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north easterly side of love lane crewe and nantwich cheshire T.N. ch 103939 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0