PRIVATE LABEL MORTGAGE SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PRIVATE LABEL MORTGAGE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02096862 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PRIVATE LABEL MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 43-45 Portman Square W1H 6LY London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PRIVATE LABEL MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour PRIVATE LABEL MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | 4.71 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Young en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Gray en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Heol Ygamlas Parc Nantgarw Treforest Cardiff South Glamorgan CF15 7QU le 10 janv. 2011 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Phillip Simpson en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 5 Arlington Square Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1WA le 20 août 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Russel Gray en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Young en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Knight en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Godfrey Blight en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Jefrey Lundgren en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 13 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PRIVATE LABEL MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMONDS, Karen Britt | Secrétaire | Badgers Barn Farthings Paddock BA7 7QA Alford Somerset | British | 42484650004 | ||||||
| FIELD, Barry John | Secrétaire | Coppets Lowicks Road Tilford GU10 2EZ Farnham Surrey | British | 17480670001 | ||||||
| HAMZEHPOUR, Tammy | Secrétaire | 7816 Bush Lake Drive Bloomington Minnesota Mn 55438 Usa | American | 64501790002 | ||||||
| MAJITHIA, Sukhen | Secrétaire | 47 Oakfield Avenue HA3 8TH Harrow Middlesex | British | 54916300001 | ||||||
| MURISON, Robert William | Secrétaire | 59 Lordington PO18 9DX Chichester West Sussex | British | 97871790001 | ||||||
| SIMPSON, Phillip Bertram | Secrétaire | 16 Gatscombe Crescent Hanover Park SL5 7HA Ascot | British | 54705580002 | ||||||
| ACHESON, William Brian | Administrateur | Eastern Gate Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berkshire | American | 100315920003 | ||||||
| BLIGHT, Godfrey | Administrateur | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | United Kingdom | British | 135102120001 | |||||
| BLIGHT, Godfrey | Administrateur | 7 The Crossways Onslow Village GU2 7QG Guildford Surrey | England | British | 82701870001 | |||||
| BRADLEY, Colin Walter | Administrateur | Williamsgate The Street RG27 0PJ Eversley Hampshire | British | 70001440003 | ||||||
| FIELD, Barry John | Administrateur | Coppets Lowicks Road Tilford GU10 2EZ Farnham Surrey | United Kingdom | British | 17480670001 | |||||
| FREEMAN, Timothy, Mr. | Administrateur | 94 Oak Hill Crescent IG8 9PQ Woodford Green Essex | England | British | 141863550001 | |||||
| GARFIELD, John Stuart Godwin | Administrateur | 26 Musgrave Crescent SW6 4QE London | British | 22311780006 | ||||||
| GRAY, Mark Russel | Administrateur | Portman Square W1H 6LY London 43-45 | England | British | 104512610002 | |||||
| KELLY, Michael John Ruthven | Administrateur | Foxwood Fishery Road Bray SL6 1UP Maidenhead Berkshire | England | British | 10749350001 | |||||
| KNIGHT, Simon Timothy Talbot | Administrateur | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | United Kingdom | British | 135101910001 | |||||
| KNIGHT, Simon Timothy Talbot | Administrateur | Ashbury Wood Compton Way Moor Park GU10 1RD Farnham Surrey | England | British | 154683790001 | |||||
| KNIGHT, Stephen Charles | Administrateur | G M A C Rfc Eastern Gate, Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berks | United Kingdom | British | 126231430003 | |||||
| LUNDGREN, Jefrey Andrew | Administrateur | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 130391340002 | |||||
| MURISON, Robert William | Administrateur | 59 Lordington PO18 9DX Chichester West Sussex | England | British | 97871790001 | |||||
| NORDEEN, Christopher Jon | Administrateur | The Turnberry 8 Sheridan Grange Broomhall Lane SL5 0BX Sunningdale Berkshire | Usa | 61535870001 | ||||||
| SEARLE, Barry Roy | Administrateur | 17 Waverley Way RG40 4YD Wokingham Berkshire | British | 70897720001 | ||||||
| WESTNUT, Charles George Mackenzie | Administrateur | 54 Eaton Square SW1W 9BE London | British | 28026680001 | ||||||
| YOUNG, James | Administrateur | Portman Square W1H 6LY London 43-45 | Usa | American | 149646860001 |
PRIVATE LABEL MORTGAGE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of deposit | Créé le 08 mai 1992 Livré le 09 mai 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 8/5/92 | |
Brèves mentions The deposit fund created by the deed £8,480.00. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 mai 1990 Livré le 30 mai 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
PRIVATE LABEL MORTGAGE SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0