WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED

WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02100070
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WILLIAM COOK PARKWAY LIMITED25 avr. 199525 avr. 1995
    WILLIAM COOK STEEL CASTINGS LIMITED26 mars 198726 mars 1987
    TRAVERSE LIMITED16 févr. 198716 févr. 1987

    Quels sont les derniers comptes de WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire de créanciers

    3 pagesREST-CVL

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    pages600

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire de créanciers

    2 pagesREST-CVL

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pages4.72

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 août 2012

    14 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de , 93 Queen Street, Sheffield, South Yorkshire, S1 1WF, England le 16 août 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Changement d'adresse du siège social de , Parkway Avenue, Sheffield, S9 4UL le 07 juil. 2011

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 27 mars 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 août 2010

    État du capital au 19 août 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 28 mars 2009

    15 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288c

    Comptes annuels établis au 29 mars 2008

    19 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re guarantee / debenture & intercreditor deed 29/01/2008
    RES13

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HODGSON, Michael Keith
    26 Knowle Lane
    S11 9SH Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    26 Knowle Lane
    S11 9SH Sheffield
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant95103110001
    COOK, Andrew John, Sir
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    EnglandBritishChairman102659430002
    GRAYLEY, Kevin John
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director43273780002
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant83552520001
    CARRICK, Neil Richard
    46 Highfields
    Beverley Road
    HU15 2AJ South Cave
    North Humberside
    Secrétaire
    46 Highfields
    Beverley Road
    HU15 2AJ South Cave
    North Humberside
    BritishChartered Accountant41646220001
    DONKER, Mark
    5 Church Green Boat Lane
    Sprotbrough
    DN5 7JT Doncaster
    South Yorkshire
    Secrétaire
    5 Church Green Boat Lane
    Sprotbrough
    DN5 7JT Doncaster
    South Yorkshire
    BritishAccountant104313570001
    GERARD, Ian Robert
    17 Park Hall Gardens
    Walton
    S42 7NQ Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    17 Park Hall Gardens
    Walton
    S42 7NQ Chesterfield
    Derbyshire
    British14710470001
    MASKREY, Neil Anthony
    High Croft
    Eaton Hill Baslow
    DE45 1SB Bakewell
    Derbyshire
    Secrétaire
    High Croft
    Eaton Hill Baslow
    DE45 1SB Bakewell
    Derbyshire
    BritishAccountant78393640002
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    Secrétaire
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    BritishAccountant43273740002
    MUSGROVE, Kevin
    2 Walker Close
    Grenoside
    S35 8SA Sheffield
    Secrétaire
    2 Walker Close
    Grenoside
    S35 8SA Sheffield
    British60210260001
    WROE, Neil Martin
    9 Woodside Lodge Storthes Hall
    Lane Kirkburton
    HD8 0PD Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    9 Woodside Lodge Storthes Hall
    Lane Kirkburton
    HD8 0PD Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAccountant103347640001
    ASH, Kevin John
    Hunters Moon
    7 The Yeld
    DE45 1FH Bakewell
    Derbyshire
    Administrateur
    Hunters Moon
    7 The Yeld
    DE45 1FH Bakewell
    Derbyshire
    BritishGeneral Manager50303470002
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant83552520001
    CARRICK, Neil Richard
    46 Highfields
    Beverley Road
    HU15 2AJ South Cave
    North Humberside
    Administrateur
    46 Highfields
    Beverley Road
    HU15 2AJ South Cave
    North Humberside
    BritishChartered Accountant41646220001
    CUMMINGS, Bruce
    28 Pennywell Drive
    Holymoorside
    S42 7EY Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    28 Pennywell Drive
    Holymoorside
    S42 7EY Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector15678790001
    GEORGE, Eric
    60 Hallam Road
    S60 3EB Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    60 Hallam Road
    S60 3EB Rotherham
    South Yorkshire
    BritishDirector15678800001
    GERARD, Ian Robert
    17 Park Hall Gardens
    Walton
    S42 7NQ Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    17 Park Hall Gardens
    Walton
    S42 7NQ Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishManaging Director14710470001
    GERARD, Ian Robert
    17 Park Hall Gardens
    Walton
    S42 7NQ Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    17 Park Hall Gardens
    Walton
    S42 7NQ Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector14710470001
    HENSON, Roy
    10 Furnival Road
    S31 0HF Todwick
    South Yorkshire
    Administrateur
    10 Furnival Road
    S31 0HF Todwick
    South Yorkshire
    BritishDirector41673210001
    MASKREY, Neil Anthony
    25 Stowe Avenue
    Millhouses
    S7 2GP Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    25 Stowe Avenue
    Millhouses
    S7 2GP Sheffield
    South Yorkshire
    BritishAccountant78393640001
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    Administrateur
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    BritishCompany Director43273740002
    MOORE, Peter John
    60 Chelsea Road
    Brincliffe
    S11 9BR Sheffield
    Administrateur
    60 Chelsea Road
    Brincliffe
    S11 9BR Sheffield
    BritishDirector43273740001
    MUSGROVE, Kevin
    2 Walker Close
    Grenoside
    S35 8SA Sheffield
    Administrateur
    2 Walker Close
    Grenoside
    S35 8SA Sheffield
    United KingdomBritishDirector60210260001
    PARKES, Brian
    Holly Lodge 70 Woodstock Road
    Loxley
    S6 6TG Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Holly Lodge 70 Woodstock Road
    Loxley
    S6 6TG Sheffield
    South Yorkshire
    BritishSales Director15678810002
    PARKES, Brian
    449 Walkley Bank Road
    S6 5AQ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    449 Walkley Bank Road
    S6 5AQ Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector15678810001
    STEVENSON, Trevor William
    92 Holborn View
    Codnor
    DE5 9RF Ripley
    Derbyshire
    Administrateur
    92 Holborn View
    Codnor
    DE5 9RF Ripley
    Derbyshire
    EnglandBritishSales Director52056300001
    WATERHOUSE, Brian Roy
    Sunny Bank,36 The Hill
    Cromford
    DE4 3QR Matlock
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Sunny Bank,36 The Hill
    Cromford
    DE4 3QR Matlock
    Derbyshire
    England
    BritishProduction Director33434520001

    WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 08 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • William Cook Holdings Limited
    Transactions
    • 08 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 juin 2006
    Livré le 04 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Catton foundry cross green approach leeds t/n WYK458821, inkerman tow law county durham t/n DU169329, bond isle works stanhope durham t/n DU178165 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Aj Cook Pension Scheme
    Transactions
    • 04 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Debenture
    Créé le 17 août 2004
    Livré le 27 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the royal bank of scotland PLC and barclays bank PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 27 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 17 août 2004
    Livré le 26 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of all or any group company to the chargee under or pursuant to any finance document under the terms of the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Andrew John Cook Cbe (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 26 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Deed of adherence to a composite guarantee and debenture dated 23RD january 1997
    Créé le 04 avr. 1997
    Livré le 16 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and payment obligations which are as at 4TH april 1997 or may at any time thereafter be due, owing or incurred in any manner whatsoever from any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) and to the security beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 juin 1995
    Livré le 30 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 juin 1995
    Livré le 28 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Meespierson Nv
    Transactions
    • 28 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mars 1988
    Livré le 22 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 14 août 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 26 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WILLIAM COOK SHEFFIELD LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 août 2011Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Russell
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    practitioner
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Andrew Philip Wood
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    practitioner
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0