ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02101108 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED ?
Adresse du siège social | KROLL ADVISORY LTD The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 42 pages | LIQ13 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Velocity 1 Brooklands Drive Brooklands Weybridge Surrey KT13 0SL England à The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 14 déc. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Cessation de Iss Workwear and Washroom Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Iss Brightspark Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov. 2022 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 12 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 1 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Joanne Roberts en tant qu'administrateur le 22 oct. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bruce Andrew Van Der Waag en tant que directeur le 22 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 1 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephanie Louise Hamilton en tant que directeur le 31 juil. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Elizabeth Michelle Benison en tant qu'administrateur le 21 mai 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Stephanie Louise Hamilton en tant qu'administrateur le 22 févr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip John Leigh en tant que directeur le 28 févr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 janv. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENISON, Elizabeth Michelle | Administrateur | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | England | British | Chief Executive Officer | 283639230001 | ||||
ROBERTS, Joanne | Administrateur | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | England | British | Chief Financial Officer | 288760280001 | ||||
ANDERSEN, Henrik | Secrétaire | 14 Hale End Hook Heath GU22 0LH Woking Surrey | Danish | Cfo | 106962600002 | |||||
GRAVENHORST, Jeff Olsen | Secrétaire | 6 Cross Acres Pyrford Woods GU22 8QS Woking Surrey | Danish | Manager | 85332130001 | |||||
GRAY, Ian Anthony Alan | Secrétaire | 44 Crawthew Grove East Dulwich SE22 9AB London | British | Accountant Finance Director | 73745880003 | |||||
STUBBINGS, Howard Bayley | Secrétaire | 22 Ashdene Road Heaton Mersey SK4 3AD Stockport Cheshire | British | 2295590001 | ||||||
AHMED, Jahangeer | Administrateur | Hammond End Farnham Common SL2 3LG Slough 25 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 73162010004 | ||||
ANDERSEN, Henrik | Administrateur | 14 Hale End Hook Heath GU22 0LH Woking Surrey | United Kingdom | Danish | Cfo | 106962600002 | ||||
ARMSTRONG, Anthony | Administrateur | 8 Blairmore Drive BL3 4UE Bolton Lancashire | British | Company Director | 2295600001 | |||||
BRABIN, Matthew Edward Stanley | Administrateur | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | Chief Executive Officer | 92458830002 | ||||
BRABIN, Matthew Edward Stanley | Administrateur | 12 Marshall Road GU7 3AS Godalming Surrey | England | British | Finance Director | 92458830002 | ||||
COX, Simon Paul | Administrateur | Flat 4 Campden House Court 42 Gloucester Walk Kensington W8 4HU London | England | British | Director | 73457870001 | ||||
GETHIN, Corinne | Administrateur | 3 Fairwater Drive New Haw KT15 3LP Addlestone Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 79809500001 | ||||
GRAVENHORST, Jeff Olsen | Administrateur | 6 Cross Acres Pyrford Woods GU22 8QS Woking Surrey | Danish | Manager | 85332130001 | |||||
GRAY, Ian Anthony Alan | Administrateur | 44 Crawthew Grove East Dulwich SE22 9AB London | British | Accountant Finance Director | 73745880003 | |||||
HAMILTON, Stephanie Louise | Administrateur | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | United Kingdom | British | Head People & Culture | 280463790001 | ||||
HARDERN, Michael Rushworth | Administrateur | 14 Stonechat Close Ellenbrook M28 7XQ Worsley Manchester | British | General Management | 37738600002 | |||||
LEIGH, Philip John | Administrateur | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | Chief Operating Officer | 156680600002 | ||||
MAHONEY, Kevin David | Administrateur | 6 Ferrymans Quay William Morris Way SW6 2UT London | United Kingdom | British | Director | 63238350002 | ||||
MAS, Paul John | Administrateur | 43 Cherry Lane Hampton Magna CV35 8SP Warwick Warwickshire | British | Managing Director | 74510680001 | |||||
OPENSHAW, Robert David | Administrateur | Millers Brook Chertsey Road Chobham GU24 8NB Woking Surrey | England | British | Chief Operating Officer | 71614180002 | ||||
PATEL, Purvin Kumar Madhusudan | Administrateur | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | Chief Executive Officer | 271205360001 | ||||
PERKS, Colin | Administrateur | Haydock House Haydock Lane Bromley Cross BL7 9QA Bolton Lancashire | British | Company Director | 2295550001 | |||||
PLUCNAR JENSEN, Barbara | Administrateur | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | Danish | Chief Financial Officer | 216409100001 | ||||
RENSHAW, Edward Charles | Administrateur | 4a Peakdale Avenue Heald Green SK8 3QL Cheadle Cheshire | British | Company Director | 2295610001 | |||||
SHAW, John Herbert | Administrateur | Neidpath Church Road BL1 6HJ Bolton Lancashire | British | Company Director | 3117340001 | |||||
STUBBINGS, Howard Bayley | Administrateur | 22 Ashdene Road Heaton Mersey SK4 3AD Stockport Cheshire | British | Chartered Accountant | 2295590001 | |||||
SYKES, Richard Ian | Administrateur | Iss House, Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Surrey | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 93113770004 | ||||
VAN DER WAAG, Bruce Andrew | Administrateur | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | Dutch | Chief Financial Officer | 195067340001 | ||||
VESTERGAARD, Jorn | Administrateur | Iss House, Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Surrey | United Kingdom | Danish | Cfo | 198906050001 | ||||
WALKER, Richard James | Administrateur | 69 Yew Tree Drive Bredbury SK6 2HH Stockport Cheshire | British | Sales Director | 19010080001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iss Brightspark Limited | 04 nov. 2022 | Brooklands Drive KT13 0SL Weybridge Velocity 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Iss Workwear And Washroom Services Limited | 06 avr. 2016 | Brooklands Drive KT13 0SL Weybridge Velocity 1 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Chattels mortgage | Créé le 01 sept. 1999 Livré le 02 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 16 tennant 6100E road sweepers s/n 61005000070,61005000074,61005000080. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 24 mai 1999 Livré le 24 mai 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395 being 16 wetrok duomatic 800Y scrubber driers c/w batteries and chargers s/no's as defined and all other chattels as defined. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 28 sept. 1992 Livré le 30 sept. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Goodwill uncalled capital intellectual rights. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 30 août 1988 Livré le 07 sept. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
ISS SERVISYSTEM NORTH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0