M L INTEGRATION LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | M L INTEGRATION LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02102292 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe M L INTEGRATION LIMITED ?
| Adresse du siège social | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de M L INTEGRATION LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour M L INTEGRATION LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 18 avr. 2017
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 11 mai 2016
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven David Showell en tant que directeur le 04 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Colin Smith en tant qu'administrateur le 04 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Royston Kinch en tant que directeur le 30 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kerry Phillip en tant que directeur le 13 janv. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015 | 2 pages | AP02 | ||||||||||
Nomination de Steven David Showell en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Kerry Phillip en tant qu'administrateur le 01 sept. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Stephen James Davis en tant que directeur le 01 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de M L INTEGRATION LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| SMITH, Neil Colin | Administrateur | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 204358750001 | |||||||||
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Administrateur | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Secrétaire | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | 15931960005 | ||||||||||
| DAVIDSON, Lorraine | Secrétaire | 18b Denver Road N16 5JH London | British | 103543780001 | ||||||||||
| FOLLEY, Lucy Jayne | Secrétaire | 86 Barn Mead Doddinghurst CM15 0NE Brentwood Essex | British | 57148510001 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Secrétaire | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Secrétaire | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| LISINSKI, George | Secrétaire | Russets Onslow Road SL5 0HW Ascot Berkshire | British | 53367280001 | ||||||||||
| MOORE, Paul Anthony | Secrétaire | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | 152560500001 | |||||||||||
| PARKER, Russell Charles | Secrétaire | 4 Playfair Close OL10 2LD Heywood Lancashire | British | 19551000001 | ||||||||||
| POWER, Mark Peter | Secrétaire | 8 Whitewillow Close Failsworth M35 9GG Manchester | British | 24900380002 | ||||||||||
| BONNIFACE, Colin John | Administrateur | 45 The Vale CR5 2AU Coulsdon Surrey | British | 33738940001 | ||||||||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Administrateur | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||||||
| COOPER, Nicholas Ian | Administrateur | 26 Red Lion Square WC1R 4HQ London 3rd Floor | Uk | British | 122128470002 | |||||||||
| DALZELL, David Thomas | Administrateur | Oak House New Road Shiplake RG9 3LB Henley-On-Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 26024630001 | |||||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Administrateur | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135958960001 | |||||||||
| EMANUEL, John Clive Lloyd | Administrateur | 40 Freemans Close Stoke Poges SL2 4ER Slough Berkshire | United Kingdom | British | 30066780001 | |||||||||
| FITZ, Joseph Daniel | Administrateur | 35 Aria House 5-15 Newton Street Covent Garden WC2B 5EN London | British | 70579740002 | ||||||||||
| GIBSON, Ian Jeffrey | Administrateur | Stanmore House 3 Silverdale Road RH15 0ED Burgess Hill West Sussex | England | British | 78528840005 | |||||||||
| GREENWOOD, Philip Charles | Administrateur | 5 Mayfield Road M7 3WZ Salford Manchester | British | 33738950001 | ||||||||||
| HOGGARTH, Royston | Administrateur | The Barley House Hawks Meadow Snowford Hall Farm CV33 9ES Hunningham Warwickshire | England | British | 67927330001 | |||||||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Administrateur | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | 108268030003 | |||||||||
| JONES, Michael Adrian | Administrateur | Old Mill House Poole Keynes GL7 6EE Cirencester Gloucestershire | British | 42605870003 | ||||||||||
| KINCH, Alan Royston | Administrateur | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | English | 163334420001 | |||||||||
| LEACOCK, Troy | Administrateur | Wellwood Milnthorpe Lane SO20 6HB Winchester Hampshire | British | 65496090001 | ||||||||||
| LERWILL, Robert Earl | Administrateur | Water Street WC2R 3LA London 1 | British | 51239200003 | ||||||||||
| LISINSKI, George | Administrateur | Russets Onslow Road SL5 0HW Ascot Berkshire | British | 53367280001 | ||||||||||
| MACFARLANE, George Angus | Administrateur | Brockley Lodge Brockley Grove Hutton CM13 2JJ Brentwood Essex | British | 32836260003 | ||||||||||
| MAYO, David | Administrateur | 2 Holyrood House 434 Bury Old Road M25 1PQ Preswich Manchester | British | 37728900001 | ||||||||||
| MORGAN, Nicola Jane | Administrateur | 58 Farnham Road GU2 4PE Guildford Surrey | British | 123399870001 | ||||||||||
| NORTON, Graham Howard | Administrateur | Storrs Hill Cottage White Rose Lane GU22 7LB Woking Surrey | British | 91014890001 | ||||||||||
| PHILLIP, Kerry | Administrateur | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 185033430001 | |||||||||
| POWER, Mark Peter | Administrateur | 8 Whitewillow Close Failsworth M35 9GG Manchester | British | 24900380002 | ||||||||||
| POWER, Mark Peter | Administrateur | 8 Whitewillow Close Failsworth M35 9GG Manchester | British | 24900380002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur M L INTEGRATION LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ml Integration Group Limited | 06 avr. 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
M L INTEGRATION LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 30 nov. 1999 Livré le 02 déc. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 mars 1997 Livré le 01 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or comsci limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The leasehold land known as "internet house" on the north side of watt street and west side of herbert street, chadderton, oldham, greater manchester title number GM396200.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 mars 1997 Livré le 01 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or comsci limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the leasehold land known as "internet house" on the north side of watts street and west side of herbert street, chadderton, oldham, greater manchester title number GM396200.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 30 sept. 1993 Livré le 07 oct. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H land and buildings at watts street chadderton oldham greater manchester and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and connection of any business and full benefit of all licences t/no.GM396200. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Credit agreement | Créé le 10 août 1993 Livré le 20 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £39,470.80 | |
Brèves mentions All its right title and interest in all sums payable under the insurance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Credit agreement | Créé le 30 juil. 1992 Livré le 08 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £31,685.60 | |
Brèves mentions All its right title and interest in the insurance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Credit agreement | Créé le 14 août 1991 Livré le 20 août 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £26 806.30 due under the agreement | |
Brèves mentions All its right, title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 02 déc. 1988 Livré le 22 déc. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Legal mortgage over land and buildings k/a communications mowie broadway chadderton oldham and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0