M L INTEGRATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM L INTEGRATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02102292
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M L INTEGRATION LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe M L INTEGRATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de M L INTEGRATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    M L NETWORKS LIMITED01 déc. 199701 déc. 1997
    M.L. ELECTRO-OPTICS LIMITED23 févr. 198723 févr. 1987

    Quels sont les derniers comptes de M L INTEGRATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour M L INTEGRATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 18 avr. 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 11 mai 2016

    • Capital: GBP 1,000
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Steven David Showell en tant que directeur le 04 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Neil Colin Smith en tant qu'administrateur le 04 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2015

    État du capital au 28 oct. 2015

    • Capital: GBP 201,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Alan Royston Kinch en tant que directeur le 30 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kerry Phillip en tant que directeur le 13 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015

    2 pagesAP02

    Nomination de Steven David Showell en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    7 pagesAA

    Nomination de Kerry Phillip en tant qu'administrateur le 01 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Stephen James Davis en tant que directeur le 01 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 oct. 2014

    État du capital au 01 oct. 2014

    • Capital: GBP 201,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de M L INTEGRATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004
    SMITH, Neil Colin
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish204358750001
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    DAVIDSON, Lorraine
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    Secrétaire
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    British103543780001
    FOLLEY, Lucy Jayne
    86 Barn Mead
    Doddinghurst
    CM15 0NE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    86 Barn Mead
    Doddinghurst
    CM15 0NE Brentwood
    Essex
    British57148510001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secrétaire
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secrétaire
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    LISINSKI, George
    Russets Onslow Road
    SL5 0HW Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    Russets Onslow Road
    SL5 0HW Ascot
    Berkshire
    British53367280001
    MOORE, Paul Anthony
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    152560500001
    PARKER, Russell Charles
    4 Playfair Close
    OL10 2LD Heywood
    Lancashire
    Secrétaire
    4 Playfair Close
    OL10 2LD Heywood
    Lancashire
    British19551000001
    POWER, Mark Peter
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    Secrétaire
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    British24900380002
    BONNIFACE, Colin John
    45 The Vale
    CR5 2AU Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    45 The Vale
    CR5 2AU Coulsdon
    Surrey
    British33738940001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Administrateur
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    COOPER, Nicholas Ian
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    Administrateur
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    UkBritish122128470002
    DALZELL, David Thomas
    Oak House
    New Road Shiplake
    RG9 3LB Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Oak House
    New Road Shiplake
    RG9 3LB Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish26024630001
    DAVIS, Philip Stephen James
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135958960001
    EMANUEL, John Clive Lloyd
    40 Freemans Close
    Stoke Poges
    SL2 4ER Slough
    Berkshire
    Administrateur
    40 Freemans Close
    Stoke Poges
    SL2 4ER Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish30066780001
    FITZ, Joseph Daniel
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    Administrateur
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    British70579740002
    GIBSON, Ian Jeffrey
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish78528840005
    GREENWOOD, Philip Charles
    5 Mayfield Road
    M7 3WZ Salford
    Manchester
    Administrateur
    5 Mayfield Road
    M7 3WZ Salford
    Manchester
    British33738950001
    HOGGARTH, Royston
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    Administrateur
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    EnglandBritish67927330001
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Administrateur
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    JONES, Michael Adrian
    Old Mill House
    Poole Keynes
    GL7 6EE Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Old Mill House
    Poole Keynes
    GL7 6EE Cirencester
    Gloucestershire
    British42605870003
    KINCH, Alan Royston
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish163334420001
    LEACOCK, Troy
    Wellwood
    Milnthorpe Lane
    SO20 6HB Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Wellwood
    Milnthorpe Lane
    SO20 6HB Winchester
    Hampshire
    British65496090001
    LERWILL, Robert Earl
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    Administrateur
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    British51239200003
    LISINSKI, George
    Russets Onslow Road
    SL5 0HW Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Russets Onslow Road
    SL5 0HW Ascot
    Berkshire
    British53367280001
    MACFARLANE, George Angus
    Brockley Lodge Brockley Grove
    Hutton
    CM13 2JJ Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Brockley Lodge Brockley Grove
    Hutton
    CM13 2JJ Brentwood
    Essex
    British32836260003
    MAYO, David
    2 Holyrood House
    434 Bury Old Road
    M25 1PQ Preswich
    Manchester
    Administrateur
    2 Holyrood House
    434 Bury Old Road
    M25 1PQ Preswich
    Manchester
    British37728900001
    MORGAN, Nicola Jane
    58 Farnham Road
    GU2 4PE Guildford
    Surrey
    Administrateur
    58 Farnham Road
    GU2 4PE Guildford
    Surrey
    British123399870001
    NORTON, Graham Howard
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    Administrateur
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    British91014890001
    PHILLIP, Kerry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish185033430001
    POWER, Mark Peter
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    Administrateur
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    British24900380002
    POWER, Mark Peter
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    Administrateur
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    British24900380002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur M L INTEGRATION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3252903
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    M L INTEGRATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1999
    Livré le 02 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or comsci limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold land known as "internet house" on the north side of watt street and west side of herbert street, chadderton, oldham, greater manchester title number GM396200.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand the Banks (Or Any of Them) as Defined Therein
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or comsci limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the leasehold land known as "internet house" on the north side of watts street and west side of herbert street, chadderton, oldham, greater manchester title number GM396200.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand the Banks (Or Any of Them) as Defined Therein
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1993
    Livré le 07 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land and buildings at watts street chadderton oldham greater manchester and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and connection of any business and full benefit of all licences t/no.GM396200. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 10 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £39,470.80
    Brèves mentions
    All its right title and interest in all sums payable under the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 30 juil. 1992
    Livré le 08 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £31,685.60
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 08 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 14 août 1991
    Livré le 20 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £26 806.30 due under the agreement
    Brèves mentions
    All its right, title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 20 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 déc. 1988
    Livré le 22 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage over land and buildings k/a communications mowie broadway chadderton oldham and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 27 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0