MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED

MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02103601
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Halesfield 2
    TF7 4QH Telford
    Shropshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRADESOURCE LIMITED25 sept. 198725 sept. 1987
    ASTHALL PRINTING LIMITED25 févr. 198725 févr. 1987

    Quels sont les derniers comptes de MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 avr. 2013

    État du capital au 09 avr. 2013

    • Capital: GBP 51,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Lee Roberts le 13 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    10 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    10 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Antony James Banks le 29 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Lee Roberts le 29 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Martin Reid le 29 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Rigby le 29 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan David Griffiths le 29 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Mail Solutions Stafford Park 9 Telford Shropshire TF3 3BZ le 29 sept. 2011

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Edward Prescott le 29 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Philip Martin Reid le 29 sept. 2011

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Robert Souster le 29 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Lee Roberts le 15 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Philip Martin Reid le 15 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Rigby le 15 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Antony James Banks le 15 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REID, Philip Martin
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    BritishDirector57277220001
    BANKS, Antony James
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    BritishDirector99144280001
    GRIFFITHS, Alan David
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector35303410004
    PRESCOTT, Simon Edward
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector72479260002
    REID, Philip Martin
    Halesfield 2
    TF7 4QH Telford
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Halesfield 2
    TF7 4QH Telford
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant57277220001
    RIGBY, Paul
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector122741700001
    ROBERTS, Lee
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector50789080003
    SOUSTER, Mark Robert
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    TF7 4QH Telford
    Halesfield 2
    Shropshire
    United Kingdom
    BritishDirector50789040003
    BANKS, Antony James
    Bramblings
    High Street
    PE16 0LT Upper Dean
    Huntingdon
    Secrétaire
    Bramblings
    High Street
    PE16 0LT Upper Dean
    Huntingdon
    British99144280001
    HUTCHERSON, John Michael
    21 Lancaster Close
    Wollaston
    NN29 7PD Wellingborough
    Northamptonshire
    Secrétaire
    21 Lancaster Close
    Wollaston
    NN29 7PD Wellingborough
    Northamptonshire
    British10898310001
    MAUGHAN, Anna
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    Secrétaire
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    British53071850001
    PAGE, Adrian Peter
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    Secrétaire
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant50576960001
    STACEY, Alan Edward
    28 Edinburgh Close
    LE16 7QQ Market Harborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    28 Edinburgh Close
    LE16 7QQ Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant50789190001
    BERTRAM, Andrew Stuart
    46 Kings Lane
    Little Harrowden
    NN9 5BL Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    46 Kings Lane
    Little Harrowden
    NN9 5BL Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishDirector96094060001
    HUTCHERSON, John Michael
    21 Lancaster Close
    Wollaston
    NN29 7PD Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    21 Lancaster Close
    Wollaston
    NN29 7PD Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishDirector10898310001
    IRVING, John Leslie
    3-5 North Street
    NN7 3JB Rothersthorpe
    Northamptonshire
    Administrateur
    3-5 North Street
    NN7 3JB Rothersthorpe
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector10898330001
    KIPLING, Neil William Stuart
    15 The Downs
    NN9 5YP Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    15 The Downs
    NN9 5YP Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishDirector10898340002
    PAGE, Adrian Peter
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    Administrateur
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant50576960001
    PENNA, David Malcolm
    49 Borrowcop Lane
    WS14 9DG Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    49 Borrowcop Lane
    WS14 9DG Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector14573060001
    SHERMAN, Christopher Robert
    Elm Cottage
    City Corner, Hinton Parva
    SN4 0DH Swindon
    Administrateur
    Elm Cottage
    City Corner, Hinton Parva
    SN4 0DH Swindon
    BritishDirector83550360003
    STACEY, Alan Edward
    28 Edinburgh Close
    LE16 7QQ Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    28 Edinburgh Close
    LE16 7QQ Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant50789190001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Administrateur
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    BritishFinancial Accountant36622750002

    MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 16 avr. 2007
    Livré le 21 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 juil. 2004
    Livré le 27 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 06 mai 1997
    Livré le 19 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys due or owing from time to time owing to the company under or by virtue of the contract(s) being trade indemnity PLC credit insurance policy number 100117201 together with the benefit of all securities for the same.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 19 déc. 1996
    Livré le 24 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and kelexcel limited to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 24 févr. 1988
    Livré le 29 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge by way of assignment of the timson 2 colour T24 business forms press serial no 18711 together with all additions alterations accessories (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 29 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 févr. 1988
    Livré le 11 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 18 janv. 1988
    Livré le 20 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge by way of assignment of timson two colour T24 business forms press serial no 18710 together with all additions alterations accessories (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 20 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of deposit account moneys
    Créé le 21 déc. 1987
    Livré le 29 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assignment of the sum of £250,000 or such sum or part thereof as is for the time being standing to the credit of the deposit account with investors in industry group PLC (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 19 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 1987
    Livré le 29 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 19 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0