MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02103601 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?
Adresse du siège social | Halesfield 2 TF7 4QH Telford Shropshire United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Lee Roberts le 13 févr. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2012 | 10 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 10 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Antony James Banks le 29 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Lee Roberts le 29 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Martin Reid le 29 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Rigby le 29 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alan David Griffiths le 29 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Mail Solutions Stafford Park 9 Telford Shropshire TF3 3BZ le 29 sept. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Edward Prescott le 29 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Philip Martin Reid le 29 sept. 2011 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Robert Souster le 29 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2010 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Lee Roberts le 15 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Philip Martin Reid le 15 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Rigby le 15 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Antony James Banks le 15 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REID, Philip Martin | Secrétaire | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | British | Director | 57277220001 | |||||
BANKS, Antony James | Administrateur | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | British | Director | 99144280001 | |||||
GRIFFITHS, Alan David | Administrateur | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 35303410004 | ||||
PRESCOTT, Simon Edward | Administrateur | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 72479260002 | ||||
REID, Philip Martin | Administrateur | Halesfield 2 TF7 4QH Telford Shropshire United Kingdom | England | British | Accountant | 57277220001 | ||||
RIGBY, Paul | Administrateur | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 122741700001 | ||||
ROBERTS, Lee | Administrateur | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 50789080003 | ||||
SOUSTER, Mark Robert | Administrateur | TF7 4QH Telford Halesfield 2 Shropshire United Kingdom | British | Director | 50789040003 | |||||
BANKS, Antony James | Secrétaire | Bramblings High Street PE16 0LT Upper Dean Huntingdon | British | 99144280001 | ||||||
HUTCHERSON, John Michael | Secrétaire | 21 Lancaster Close Wollaston NN29 7PD Wellingborough Northamptonshire | British | 10898310001 | ||||||
MAUGHAN, Anna | Secrétaire | 404 Chester Road Boldmere B73 5BS Sutton Coldfield | British | 53071850001 | ||||||
PAGE, Adrian Peter | Secrétaire | 11 Shadows Lane Congerstone CV13 6NF Nuneaton Warwickshire | British | Chartered Accountant | 50576960001 | |||||
STACEY, Alan Edward | Secrétaire | 28 Edinburgh Close LE16 7QQ Market Harborough Leicestershire | British | Accountant | 50789190001 | |||||
BERTRAM, Andrew Stuart | Administrateur | 46 Kings Lane Little Harrowden NN9 5BL Wellingborough Northamptonshire | British | Director | 96094060001 | |||||
HUTCHERSON, John Michael | Administrateur | 21 Lancaster Close Wollaston NN29 7PD Wellingborough Northamptonshire | British | Director | 10898310001 | |||||
IRVING, John Leslie | Administrateur | 3-5 North Street NN7 3JB Rothersthorpe Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 10898330001 | ||||
KIPLING, Neil William Stuart | Administrateur | 15 The Downs NN9 5YP Wellingborough Northamptonshire | British | Director | 10898340002 | |||||
PAGE, Adrian Peter | Administrateur | 11 Shadows Lane Congerstone CV13 6NF Nuneaton Warwickshire | British | Chartered Accountant | 50576960001 | |||||
PENNA, David Malcolm | Administrateur | 49 Borrowcop Lane WS14 9DG Lichfield Staffordshire | British | Director | 14573060001 | |||||
SHERMAN, Christopher Robert | Administrateur | Elm Cottage City Corner, Hinton Parva SN4 0DH Swindon | British | Director | 83550360003 | |||||
STACEY, Alan Edward | Administrateur | 28 Edinburgh Close LE16 7QQ Market Harborough Leicestershire | British | Accountant | 50789190001 | |||||
WHITTY, Brian Howard | Administrateur | Ruxley House Rowney Green Lane Rowney Green B48 7QF Alvechurch Worcestershire | British | Financial Accountant | 36622750002 |
MAIL SOLUTIONS PRINT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 16 avr. 2007 Livré le 21 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 23 juil. 2004 Livré le 27 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment | Créé le 06 mai 1997 Livré le 19 mai 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All moneys due or owing from time to time owing to the company under or by virtue of the contract(s) being trade indemnity PLC credit insurance policy number 100117201 together with the benefit of all securities for the same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 19 déc. 1996 Livré le 24 déc. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and kelexcel limited to the chargee | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 24 févr. 1988 Livré le 29 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge by way of assignment of the timson 2 colour T24 business forms press serial no 18711 together with all additions alterations accessories (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 févr. 1988 Livré le 11 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 18 janv. 1988 Livré le 20 janv. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge by way of assignment of timson two colour T24 business forms press serial no 18710 together with all additions alterations accessories (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of deposit account moneys | Créé le 21 déc. 1987 Livré le 29 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Assignment of the sum of £250,000 or such sum or part thereof as is for the time being standing to the credit of the deposit account with investors in industry group PLC (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 21 déc. 1987 Livré le 29 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0