SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED

SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSWANTON NOVERS ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02107230
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Yorkshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BEATCREST LIMITED06 mars 198706 mars 1987

    Quels sont les derniers comptes de SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 mai 2012

    État du capital au 25 mai 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2011 au 31 mars 2012

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Kazushi Ogura en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Kenji Murai en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Healy en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Michael Healy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Fraser en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Ian Vincent Ellis en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 3 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB le 02 août 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael Joseph Anthony Healy le 20 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Joseph Anthony Healy le 20 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Ellis Fraser le 20 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIS, Ian Vincent
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    British162130370001
    MURAI, Kenji
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapaneseNone95702340002
    OGURA, Kazushi
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapaneseNone150485750001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Secrétaire
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    British99111340001
    HUTHERSALL, Robert
    17 Corstorphine Road
    EH12 6DD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Secrétaire
    17 Corstorphine Road
    EH12 6DD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British3204110001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Secrétaire
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Administrateur
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    BritishGroup Director Of Finance79800380001
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUkCompany Director28393850006
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director99111340001
    HOUSTON, John Mclellan
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    Administrateur
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    BritishAccountant712840002
    HUTHERSALL, Robert
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    Administrateur
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    BritishAccountant3204110005
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    BritishFinance Director41923940001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    BritishGroup Company Secretary41923940001
    OWENS, Stanley Hart
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    Administrateur
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    AmericanFinance Director75755850002
    PARKER, Timothy Charles
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director126476060001

    SWANTON NOVERS ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of confirmation
    Créé le 25 mai 2007
    Livré le 06 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any debtor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of the Secured Parties
    Transactions
    • 06 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A composite mortgage
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 11 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any debtor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The l/h property known as conway road llandudno gynedd. The freehold property known as 501 london road boxmoor hemel hempstead t/n HD233716 being 501 london road boxmoor hemel hempstead. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of the Secured Parties
    Transactions
    • 11 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 04 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any debtor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for and on Behalf of the Secured Parties
    Transactions
    • 04 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 04 avr. 1989
    Livré le 10 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    166 east street epsom surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 12 janv. 1989
    Livré le 24 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    79 & 81 & land adjoining 85, 87 89 brighton road surbiton l/b of kingston upon thames t/nos sgl 98941 & sy 118339 & sy 185700 & sy 246289 & sy 118340 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 févr. 1988
    Livré le 09 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the S.W. side of heathfield rd, ellesmere port, cheshire. T.no:- ch 212828, f/h property k/a - land at the corner of whitby rd, & heathfield rd, ellesmere port cheshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 déc. 1987
    Livré le 18 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Gillingham service station watling street, gillingham kent t/no- k 249268. &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 nov. 1987
    Livré le 08 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    37, 39 and 41 brighton road, shoreham-by-sea west sussex and/or the proceeds of sale thereof, floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 oct. 1987
    Livré le 21 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property k/a red garage conway road, llandudno, gwynedd. &/Or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    8/8A stakes hill road, waterlooville, hampshire t/no- hp 146953 f/hold property k/a bonds garage & workshop 6 stakes hill road waterlooville portsmouth hampshire &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 12 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Site at junction of heybridge way and leabridge road E.10 forming part of 225/227 leabridge road & stirling works flempton road, leyton l/b of waltham forest t/no - egl 90078, &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 12 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property k/a 501 london road boxmoor hemel hempstead hertfordshire &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 12 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    265, bury new road, city of salford t/no- la 83986 &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 août 1987
    Livré le 20 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The elipse garage camden road now k/a padlock service station 379/385 camden road islington t/n ln 33948 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 12 août 1987
    Livré le 18 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    140/142 stoke newington road london N16 title no:- 349137 and 125321 and/or the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 03 août 1987
    Livré le 11 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 103/105 new london road chelmsford essex and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 juil. 1987
    Livré le 10 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Edina workshops 64 hertford street westcliff road ramsgate t/n k 71725 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 juil. 1987
    Livré le 21 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings on the north side of summerland street, exeter, devon t/no- dn 170731 &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0