GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED

GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02108766
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PICK INDEPENDENCE COMPUTER SYSTEMS LIMITED10 juin 198710 juin 1987
    TINTMUSTER LIMITED11 mars 198711 mars 1987

    Quels sont les derniers comptes de GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 déc. 2012

    État du capital au 18 déc. 2012

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Barbara Ann Firth le 11 déc. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul David Gibson le 06 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011

    6 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Hilary Lowe en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Hilary Anne Lowe en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Paul Gibson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Vinodka Murria le 01 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul David Gibson le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Mark Harry Thompson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Paul David Gibson le 01 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Barbara Ann Firth le 01 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010

    6 pagesAA

    Nomination de Barbara Ann Firth en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Ms Vinodka Murria en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fiona Timothy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2010 au 28 févr. 2010

    2 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FIRTH, Barbara Ann
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    British192439290001
    LOWE, Hilary Anne
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    British159478080001
    PYLE, Patricia Anne
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    Preston
    Secrétaire
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    Preston
    British22020080002
    DILLON, Pauline Anne
    18 Lower Landedmans
    Westhoughton
    BL5 2QL Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    18 Lower Landedmans
    Westhoughton
    BL5 2QL Bolton
    Lancashire
    British22020100001
    DILLON, Peter Gerald
    18 Lower Landedmans
    Westhoughton
    BL5 2QL Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    18 Lower Landedmans
    Westhoughton
    BL5 2QL Bolton
    Lancashire
    British22020110001
    FRANKLIN, Christopher John
    7 Lytham Road
    Fulwood
    PR2 8JE Preston
    Lancashire
    Administrateur
    7 Lytham Road
    Fulwood
    PR2 8JE Preston
    Lancashire
    British67032940001
    PYLE, Alexander Derek
    22 Severn Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TE Preston
    Lancashire
    Administrateur
    22 Severn Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TE Preston
    Lancashire
    British22020120001
    PYLE, Michael Joseph
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    PR2 4XP Preston
    Lancashire
    Administrateur
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    PR2 4XP Preston
    Lancashire
    British22020090002
    PYLE, Patricia Anne
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    Preston
    Administrateur
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    Preston
    British22020080002
    ROLLINS, David
    17 Rookwood Avenue
    PR7 1RL Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    17 Rookwood Avenue
    PR7 1RL Chorley
    Lancashire
    British67032890001
    THOMPSON, Mark Harry
    The Bungalow
    Forest Crescent
    KT21 1JU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Bungalow
    Forest Crescent
    KT21 1JU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish156095450001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Holly Cottage
    Kings Lane
    SL6 9AY Cookham Dean
    Berkshire
    Administrateur
    Holly Cottage
    Kings Lane
    SL6 9AY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish161343370001

    GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 mars 2007
    Livré le 09 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 nov. 2003
    Livré le 25 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 2001
    Livré le 06 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 mars 1996
    Livré le 22 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 1990
    Livré le 28 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 17 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0