I.B.T. LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | I.B.T. LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02109154 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe I.B.T. LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Mazars Llp 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de I.B.T. LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour I.B.T. LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 15 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Victoria House Pearson Court Pearson Way, Thornaby Stockton on Tees Cleveland TS17 6PT à C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT le 25 avr. 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Victoria House Pearson Court Pearson Way Thornaby Stockton on Tees TS17 6PT | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 août 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 août 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2016 au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2015 | 11 pages | AA | ||||||||||
legacy | 71 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
Nomination de Mr Abraham Cornelis Paape en tant qu'administrateur le 10 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Klaas Pieter Den Hartogh en tant qu'administrateur le 10 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Loek Frans Jacob Kullberg en tant que directeur le 10 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Scott Thomas Cunningham en tant que directeur le 10 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Scott Thomas Cunningham en tant que secrétaire le 10 mars 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Loek Frans Jacob Kullberg le 01 févr. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Scott Thomas Cunningham le 09 juin 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de I.B.T. LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN HARTOGH, Klaas Pieter | Administrateur | Eastfield Road South Killingholme DN40 3DQ Immingham Eastfield Road South Humberside England | Netherlands | Dutch | Managing Director | 205933140001 | ||||
PAAPE, Abraham Cornelius | Administrateur | Eastfield Road South Killingholme DN40 3DQ Immingham Eastfield Road South Humberside England | Netherlands | Dutch | Group Financial Director | 205995900001 | ||||
CUNNINGHAM, Scott Thomas | Secrétaire | Portland Park ML3 7JY Hamilton 41 Athol Bank Lanarkshire Scotland | British | Finance Director | 111223770001 | |||||
MAY, Brian Warner Lang | Secrétaire | PO BOX 165 Hedon Road HU9 1YY Hull | British | 9050410002 | ||||||
MOLENAAR, Roelof | Secrétaire | Rochussenstraat 45a FOREIGN Rotterdam 3015ec Netherlands | Dutch | Director | 70774490001 | |||||
ORVIS, Peter | Secrétaire | 9 Wauldby View Swanland HU14 3RE North Ferriby North Humberside | British | Accountant | 31145130001 | |||||
RICHARD, Timothy John | Secrétaire | Close Farm Ilmer HP27 9RD Princes Risborough Buckinghamshire | British | 85213810001 | ||||||
BONE, David Kenneth | Administrateur | Foxcub Cottage Upper Street Billingford IP21 4HP Diss Norfolk | British | Director | 40294980003 | |||||
CUNNINGHAM, Scott Thomas | Administrateur | Victoria House Pearson Court Pearson Way, Thornaby TS17 6PT Stockton On Tees Cleveland | Scotland | British | Director | 191625420001 | ||||
DARVILL, Alan Christopher | Administrateur | 1 Ladygate HU17 8BH Beverley East Yorkshire | British | Company Director | 9689160001 | |||||
JEFFREY, David John | Administrateur | 1 Putlowes Drive Fleet Marston HP18 0PX Ayesbury Buckinghamshire | England | British | Director | 92362550001 | ||||
JONES, Michael | Administrateur | Shires The Paddock Stock CM4 9BG Ingatestones Essex | British | Chartered Accountant | 40295120001 | |||||
KULLBERG, Loek Frans Jacob | Administrateur | Victoria House Pearson Court Pearson Way, Thornaby TS17 6PT Stockton On Tees Cleveland | Netherlands | Dutch | Company Director | 184998400002 | ||||
MARSHALL, John Neilson Adam | Administrateur | Bell Hall Escrick YO19 6HL York | England | British | Director | 29783380003 | ||||
MARTIN, Victor William | Administrateur | The Foxes Greenway Hutton Mount CM13 2NP Shenfield Essex | British | Director | 9689140001 | |||||
MAY, Brian Warner Lang | Administrateur | PO BOX 165 Hedon Road HU9 1YY Hull | British | Company Director | 9050410002 | |||||
MOLENAAR, Roelof | Administrateur | Rochussenstraat 45a FOREIGN Rotterdam 3015ec Netherlands | Dutch | Director | 70774490001 | |||||
NOEL, Michel | Administrateur | Bergschenhoek Jf Kennedylaan 10 2661jh Netherlands | British | Finance Director | 129561360001 | |||||
PEARCH, Nicholas Keith | Administrateur | Bradfield Manor Hullavington SN14 6EU Chippenham Wiltshire | British | Company Director | 69879060001 | |||||
RICHARDS, Timothy John | Administrateur | Close End Farm Ilmer HP27 9RD Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British,Canadian | Company Director | 71050390002 | ||||
STATON, Joseph Howard | Administrateur | 5 Beech Hill Road Swanland HU14 3QY North Ferriby East Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 41340700001 | ||||
VAN DER WARDT, Harald Christiaan | Administrateur | Rotterdam 3055 Be Van Hoytemalaan 10 Netherlands | Netherlands | Dutch | Finance Director | 136444450001 | ||||
VAN WISSEN, Jacobus Cornelis Jozef | Administrateur | Dromhille 5 Oud Beijerland 3261th Netherlands | Netherlands | Dutch | Managing Director | 134737410001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur I.B.T. LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Klaas Pieter Den Hartogh | 06 avr. 2016 | Willingestraat 6 3087 An 3087AN Rotterdam 6 Netherlands | Non |
Nationalité: Dutch Pays de résidence: Netherlands | |||
Nature du contrôle
|
I.B.T. LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Créé le 09 juin 2000 Livré le 13 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 27 sept. 1999 Livré le 05 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 10 cpv, 25 litre pressure tanks, numbered IBTU125080 to IBTU125089. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 07 janv. 1997 Livré le 15 janv. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 22 nov. 1994 Livré le 28 nov. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
I.B.T. LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0