I.B.T. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéI.B.T. LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02109154
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de I.B.T. LIMITED ?

    • Transport routier de marchandises (49410) / Transports et stockage

    Où se situe I.B.T. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Mazars Llp
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de I.B.T. LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    I.B.C. TRANSPORT LIMITED11 mars 198711 mars 1987

    Quels sont les derniers comptes de I.B.T. LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour I.B.T. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    15 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Victoria House Pearson Court Pearson Way, Thornaby Stockton on Tees Cleveland TS17 6PT à C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT le 25 avr. 2018

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Victoria House Pearson Court Pearson Way Thornaby Stockton on Tees TS17 6PT

    2 pagesAD02

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 janv. 2018

    LRESSP

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 31 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2015

    11 pagesAA

    legacy

    71 pagesPARENT_ACC

    Nomination de Mr Abraham Cornelis Paape en tant qu'administrateur le 10 mars 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Klaas Pieter Den Hartogh en tant qu'administrateur le 10 mars 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Loek Frans Jacob Kullberg en tant que directeur le 10 mars 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Scott Thomas Cunningham en tant que directeur le 10 mars 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Scott Thomas Cunningham en tant que secrétaire le 10 mars 2016

    1 pagesTM02

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Loek Frans Jacob Kullberg le 01 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2015

    État du capital au 08 sept. 2015

    • Capital: GBP 25,000
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Scott Thomas Cunningham le 09 juin 2014

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de I.B.T. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DEN HARTOGH, Klaas Pieter
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Eastfield Road
    South Humberside
    England
    Administrateur
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Eastfield Road
    South Humberside
    England
    NetherlandsDutchManaging Director205933140001
    PAAPE, Abraham Cornelius
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Eastfield Road
    South Humberside
    England
    Administrateur
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Eastfield Road
    South Humberside
    England
    NetherlandsDutchGroup Financial Director205995900001
    CUNNINGHAM, Scott Thomas
    Portland Park
    ML3 7JY Hamilton
    41 Athol Bank
    Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    Portland Park
    ML3 7JY Hamilton
    41 Athol Bank
    Lanarkshire
    Scotland
    BritishFinance Director111223770001
    MAY, Brian Warner Lang
    PO BOX 165
    Hedon Road
    HU9 1YY Hull
    Secrétaire
    PO BOX 165
    Hedon Road
    HU9 1YY Hull
    British9050410002
    MOLENAAR, Roelof
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Secrétaire
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    DutchDirector70774490001
    ORVIS, Peter
    9 Wauldby View
    Swanland
    HU14 3RE North Ferriby
    North Humberside
    Secrétaire
    9 Wauldby View
    Swanland
    HU14 3RE North Ferriby
    North Humberside
    BritishAccountant31145130001
    RICHARD, Timothy John
    Close Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Close Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British85213810001
    BONE, David Kenneth
    Foxcub Cottage Upper Street
    Billingford
    IP21 4HP Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Foxcub Cottage Upper Street
    Billingford
    IP21 4HP Diss
    Norfolk
    BritishDirector40294980003
    CUNNINGHAM, Scott Thomas
    Victoria House Pearson Court
    Pearson Way, Thornaby
    TS17 6PT Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    Victoria House Pearson Court
    Pearson Way, Thornaby
    TS17 6PT Stockton On Tees
    Cleveland
    ScotlandBritishDirector191625420001
    DARVILL, Alan Christopher
    1 Ladygate
    HU17 8BH Beverley
    East Yorkshire
    Administrateur
    1 Ladygate
    HU17 8BH Beverley
    East Yorkshire
    BritishCompany Director9689160001
    JEFFREY, David John
    1 Putlowes Drive
    Fleet Marston
    HP18 0PX Ayesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Putlowes Drive
    Fleet Marston
    HP18 0PX Ayesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector92362550001
    JONES, Michael
    Shires
    The Paddock Stock
    CM4 9BG Ingatestones
    Essex
    Administrateur
    Shires
    The Paddock Stock
    CM4 9BG Ingatestones
    Essex
    BritishChartered Accountant40295120001
    KULLBERG, Loek Frans Jacob
    Victoria House Pearson Court
    Pearson Way, Thornaby
    TS17 6PT Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    Victoria House Pearson Court
    Pearson Way, Thornaby
    TS17 6PT Stockton On Tees
    Cleveland
    NetherlandsDutchCompany Director184998400002
    MARSHALL, John Neilson Adam
    Bell Hall
    Escrick
    YO19 6HL York
    Administrateur
    Bell Hall
    Escrick
    YO19 6HL York
    EnglandBritishDirector29783380003
    MARTIN, Victor William
    The Foxes
    Greenway Hutton Mount
    CM13 2NP Shenfield
    Essex
    Administrateur
    The Foxes
    Greenway Hutton Mount
    CM13 2NP Shenfield
    Essex
    BritishDirector9689140001
    MAY, Brian Warner Lang
    PO BOX 165
    Hedon Road
    HU9 1YY Hull
    Administrateur
    PO BOX 165
    Hedon Road
    HU9 1YY Hull
    BritishCompany Director9050410002
    MOLENAAR, Roelof
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Administrateur
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    DutchDirector70774490001
    NOEL, Michel
    Bergschenhoek
    Jf Kennedylaan 10
    2661jh
    Netherlands
    Administrateur
    Bergschenhoek
    Jf Kennedylaan 10
    2661jh
    Netherlands
    BritishFinance Director129561360001
    PEARCH, Nicholas Keith
    Bradfield Manor
    Hullavington
    SN14 6EU Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Bradfield Manor
    Hullavington
    SN14 6EU Chippenham
    Wiltshire
    BritishCompany Director69879060001
    RICHARDS, Timothy John
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish,CanadianCompany Director71050390002
    STATON, Joseph Howard
    5 Beech Hill Road
    Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    Administrateur
    5 Beech Hill Road
    Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    United KingdomBritishDirector41340700001
    VAN DER WARDT, Harald Christiaan
    Rotterdam
    3055 Be
    Van Hoytemalaan 10
    Netherlands
    Administrateur
    Rotterdam
    3055 Be
    Van Hoytemalaan 10
    Netherlands
    NetherlandsDutchFinance Director136444450001
    VAN WISSEN, Jacobus Cornelis Jozef
    Dromhille 5
    Oud Beijerland
    3261th
    Netherlands
    Administrateur
    Dromhille 5
    Oud Beijerland
    3261th
    Netherlands
    NetherlandsDutchManaging Director134737410001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur I.B.T. LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Klaas Pieter Den Hartogh
    Willingestraat 6
    3087 An
    3087AN Rotterdam
    6
    Netherlands
    06 avr. 2016
    Willingestraat 6
    3087 An
    3087AN Rotterdam
    6
    Netherlands
    Non
    Nationalité: Dutch
    Pays de résidence: Netherlands
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    I.B.T. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 juin 2000
    Livré le 13 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and for Each of the Agent, the Banks, the Hedging Banks and the Investors (As Defined)
    Transactions
    • 13 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattel mortgage
    Créé le 27 sept. 1999
    Livré le 05 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10 cpv, 25 litre pressure tanks, numbered IBTU125080 to IBTU125089.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 07 janv. 1997
    Livré le 15 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 1994
    Livré le 28 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    I.B.T. LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 janv. 2018Commencement of winding up
    10 nov. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    practitioner
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0