CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02110320
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RENTCO INTERNATIONAL LIMITED25 sept. 198725 sept. 1987
    VISORHEAD LIMITED13 mars 198713 mars 1987

    Quels sont les derniers comptes de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2015
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2016
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Deuxième dépôt pour la nomination de Neil Smith en tant qu'administrateur

    6 pagesRP04AP01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT à 1 More London Place London SE1 2AF le 25 avr. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 mars 2016

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Cessation de la nomination de T I P Europe Limited en tant que directeur le 05 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Cakebread en tant que directeur le 01 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Neil Campbell Smith en tant qu'administrateur le 05 févr. 2016

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    06 oct. 2016Clarification A second filed AP01 was registered on 06/10/2016

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 nov. 2015

    État du capital au 04 nov. 2015

    • Capital: GBP .1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    16 pagesAA

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Subdivision des actions au 01 déc. 2014

    8 pagesSH02

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolutions

    11,000,000 issued cumulative redeemable preference shares of £1 be sub-divided into 110,000,000 cumulative redeemable preference shares of £0.10 each 01/12/2014
    RES13

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 09 déc. 2014

    • Capital: GBP 0.10
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account to nil 01/12/2014
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 déc. 2014

    État du capital au 01 déc. 2014

    • Capital: GBP 356,027,000
    SH01

    Divers

    Section 519
    3 pagesMISC

    Démission de l'auditeur

    3 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7038430
    146358090001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    Administrateur
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    FranceUs Citizen183236480001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secrétaire
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    SMITH, Nicholas Handran
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Secrétaire
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Australian50914130001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secrétaire
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Administrateur
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Administrateur
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CAMFIELD, Ronald Frederick
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    Administrateur
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    British81395090001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Administrateur
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Administrateur
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Administrateur
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Administrateur
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Administrateur
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790001
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    Administrateur
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritish45623310001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    Administrateur
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    IRVING, Ian Richard
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    Administrateur
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    EnglandBritish41228040001
    MATTHEWS, Terence
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    Administrateur
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    British31419450002
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Administrateur
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Administrateur
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    British4764800001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Administrateur
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Administrateur
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Administrateur
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Administrateur
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    THRASHER III, Barrie Holt
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    Administrateur
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    American65472750001
    WILSON, Peter Samuel
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    British59565220001
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 juil. 1996
    Livré le 30 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 30 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account charge
    Créé le 15 mars 1994
    Livré le 23 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an indemnity contained in a sale agreement dated 14TH december 1989 and this deed (as defined therein)
    Brèves mentions
    All right title and interest of the company in and to both of the company's accounts no: 76653161 and 7943407. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC Barclays Mercantile Limited and Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 23 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 mars 1994
    Livré le 21 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a credit agreement dated 13TH february 1994 as amended on 15TH february 1994 and an agreement dated 15TH march 1994 (as defined) and any other related security documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.("the Security Trustee")as Security Trustee for Itself and for the Secured Parties (As Defined in the Debenture)
    Transactions
    • 21 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 mai 1987
    Livré le 26 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as agent and trustee for the banks and/ohe overdraft bank as defined in the deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Bank and Overdraft Bank
    Transactions
    • 26 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 10 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 mai 1987
    Livré le 26 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever agent and turstee for the banks and/or the overdroft bank as defired in the deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank
    Transactions
    • 26 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 10 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 mars 2016Commencement of winding up
    16 avr. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0