SHIRWELL BROS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHIRWELL BROS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02112968
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHIRWELL BROS LIMITED ?

    • (4521) /
    • (7499) /
    • (9999) /

    Où se situe SHIRWELL BROS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Shirwell House
    Shirwell Crescent Furzton Lake
    MK4 1GA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SHIRWELL BROS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MCCANN BROS LIMITED13 juil. 198713 juil. 1987
    VENUEPAUSE LIMITED20 mars 198720 mars 1987

    Quels sont les derniers comptes de SHIRWELL BROS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour SHIRWELL BROS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 oct. 2010

    État du capital au 21 oct. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed mccann bros LIMITED\certificate issued on 12/08/10
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    App director 20/07/2010
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Robert Green en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Mr Robert David Green en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2009

    1 pagesAA

    Cessation de la nomination de Edwin Barnes en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Mccann en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2008

    1 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2007

    1 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de SHIRWELL BROS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GREEN, Robert David
    Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    11
    Administrateur
    Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    11
    EnglandBritish76720550003
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Secrétaire
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    British76720550003
    LEWIS, Pauline Sau Yoke
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    Secrétaire
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    British107739250001
    MCCANN, Jeanette Marie
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    Secrétaire
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    British40380650002
    MCCANN, Malcolm John
    Branscome Mentmore Road
    Linslade
    LU7 Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Secrétaire
    Branscome Mentmore Road
    Linslade
    LU7 Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British16912730001
    BARNES, Edwin Sidney
    121 Arlesey Road
    Stotfold
    SG5 4HE Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    121 Arlesey Road
    Stotfold
    SG5 4HE Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish116515140001
    MCCANN, James Christopher
    The Oaks
    Heath Lane, Woburn Sands
    MK17 8TS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Oaks
    Heath Lane, Woburn Sands
    MK17 8TS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish50515850006
    MCCANN, Jeanette Marie
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    Administrateur
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    United KingdomBritish40380650002
    MCCANN, Malcolm John
    Branscome Mentmore Road
    Linslade
    LU7 Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    Branscome Mentmore Road
    Linslade
    LU7 Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British16912730001
    MCCANN, Terence Patrick
    Linford Lodge Wood Lane
    St Leger Drive Great Linford
    MK14 5AZ Milton Keynes
    Administrateur
    Linford Lodge Wood Lane
    St Leger Drive Great Linford
    MK14 5AZ Milton Keynes
    United KingdomBritish8524640002

    SHIRWELL BROS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 02 juin 1994
    Livré le 07 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 août 1987
    Livré le 10 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 20 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0