LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02115573 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED ?
| Adresse du siège social | 3 Princess Way Redhill RH1 1NP Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Kirsty Daly en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lindsey Cameron en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2010 | 20 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Priestman en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neeraj Kapur en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Andrew David Barnard en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 22 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2008 | 23 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2007 | 23 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALY, Kirsty | Secrétaire | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 161014920001 | |||||||
| BALDOCK, Alexander David | Administrateur | Westbourne Park Road W11 1EP London 218 United Kingdom | United Kingdom | British | 132330380001 | |||||
| BARNARD, Andrew David | Administrateur | Bell Cottage Bell Road RH12 3QL Warnham Bell Cottage West Sussex England | England | British | 137736080001 | |||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Administrateur | 40a Pennington Road Southborough TN4 0SL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||
| BROMLEY, Heidi Elizabeth | Secrétaire | 40 Hitchings Way RH2 8EW Reigate Surrey | British | 33605720002 | ||||||
| CAMERON, Lindsey Helen | Secrétaire | The Terrace Glenlomond KY13 9HF Kinross Suite Gleann Cottage, 1 | Other | 132335590001 | ||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Secrétaire | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||
| EVANS, Margaret Janet | Secrétaire | 17 Coniston Way RH2 0LN Reigate Surrey | British | 2289880001 | ||||||
| STRANAGHAN, Patricia Ann | Secrétaire | Flat 1 25 Somers Road RH2 9DY Reigate Surrey | British | 39114460001 | ||||||
| WHITTAKER, Carolyn Jean | Secrétaire | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||
| WRAITH CARTER, Gillian | Secrétaire | 8 Great Lime Kilns Southwater RH13 9JL Horsham West Sussex | British | 109333000001 | ||||||
| ASHWORTH, George Smith-Salmond | Administrateur | 2 Laurelsfield AL3 4BZ St Albans Hertfordshire | England | English | 152638710001 | |||||
| BEESTON, Alistair John | Administrateur | Three Oaks Vauxhall Lane Southborough TN4 0XD Tunbridge Wells Kent | British | 10670790001 | ||||||
| CARTE, Brian Addison | Administrateur | Fairfield Lodge Hardwick Close Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | United Kingdom | British | 145559220001 | |||||
| CLEMETT, Graham Colin | Administrateur | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||
| FITCH, John Derek | Administrateur | Douglas Cottage Coombe End KT2 7DQ Kingston Surrey | British | 8461210001 | ||||||
| HIGGINS, Peter | Administrateur | 2 Grange Close RH1 4LW Bletchingley Surrey | England | British | 107984310001 | |||||
| JOHNSON, Jeffrey | Administrateur | Hill House 28 Maldon Road Danbury CM3 4QH Chelmsford Essex | British | 103077710001 | ||||||
| KAPUR, Neeraj | Administrateur | The Old Granary Hillside Road GU10 3AJ Frensham Surrey | United Kingdom | British | 122158360001 | |||||
| KNOWLES, Christopher George | Administrateur | Whispering Well House Chander Hill Lane, Holymoorside S42 7HN Chesterfield Derbyshire | British | 67501900002 | ||||||
| LYNAM, Paul Anthony | Administrateur | 24 Warwick Road RG2 7AX Reading Berkshire | United Kingdom | Irish | 100755360001 | |||||
| MABERLY, Michael Alan | Administrateur | Endellion Money Row Green Holyport SL6 2NA Maidenhead Berkshire | British | 1288990001 | ||||||
| MARROW, Paul | Administrateur | The Shutters 2 Nightjar Close Ewshot GU10 5TQ Farnham Surrey | United Kingdom | British | 85771600001 | |||||
| PEARCE, Nigel | Administrateur | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||
| POWELL, Martin Edward | Administrateur | Monroe Station Road Hatfield Peverel CM3 2DS Chelmsford | United Kingdom | British | 59795080001 | |||||
| PRIESTMAN, Richard Mark | Administrateur | 31 Hove Park Villas BN3 6HH Hove Sussex | England | British | 74412220002 | |||||
| PURDY, John Douglas | Administrateur | Kendals Little Heath Lane, Potten End HP4 2RY Berkhamsted Hertfordshire | British | 68943220001 | ||||||
| ROOME, Harry Mccrea | Administrateur | The Duchies Mill Lane, Pirbright GU24 0BT Woking Surrey | England | British | 64898180001 | |||||
| STUART, John David | Administrateur | 69 Howards Thicket SL9 7NU Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 76974710001 | ||||||
| SULLIVAN, Christopher Paul | Administrateur | Princess Way RH1 1NP Redhill 3 Surrey | United Kingdom | British | 67033830004 |
LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| First panamanian naval mortgage in respect of M.V. "tarquin pride" | Créé le 30 sept. 1998 Livré le 15 oct. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee up to a maximum of us$25,000,000 | |
Brèves mentions All right title and interest in the vessel "tarquin pride" registered under the panamanian flag with official number 27318-pext-1. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| First preferred panamanian naval mortgage in respect of M.V."tarquin forth" | Créé le 09 sept. 1998 Livré le 23 sept. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee up to a maximum of us$25,000,000 | |
Brèves mentions All rights,title and interest in the vessel "tarquin forth",registered in panama with official no.27317-pext-1. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0