AIM HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAIM HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02120855
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AIM HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe AIM HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AIM HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AIM LIMITED08 mai 198708 mai 1987
    EASYCROWN LIMITED08 avr. 198708 avr. 1987

    Quels sont les derniers comptes de AIM HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AIM HOLDINGS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour AIM HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    GAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 oct. 2013

    État du capital au 02 oct. 2013

    • Capital: GBP 730,012
    SH01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2013

    12 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Nomination de Denise Williams en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Ms Vinodka Murria en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kerry Crompton en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mrs Barbara Ann Firth en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Preedy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul David Gibson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* le 25 mars 2013

    2 pagesAD01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2013 au 28 févr. 2013

    3 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Ian Preedy le 15 août 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Ian Preedy le 16 août 2012

    3 pagesCH01

    Nomination de Richard Ian Preedy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kerry Jane Crompton le 16 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012

    2 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de AIM HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176952300001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    BOOTH, Michael David
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    Secrétaire
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    British88167500001
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    FAIREY, Michael Craig
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    British113317640001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    ANDERSON, James Douglas
    4 Stirling Road
    EH5 3HY Edinburgh
    Administrateur
    4 Stirling Road
    EH5 3HY Edinburgh
    United KingdomBritish15707300001
    BAGAN, Helen
    Flat 4 Spencer Court
    Spencer Place
    N1 2AX London
    Administrateur
    Flat 4 Spencer Court
    Spencer Place
    N1 2AX London
    United KingdomBritish102014660001
    BEARPARK, Richard Mosely
    Broadfield
    16 Clifford Manor Road
    GU4 8AG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Broadfield
    16 Clifford Manor Road
    GU4 8AG Guildford
    Surrey
    EnglandBritish121373650001
    BOOTH, Michael David
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    Administrateur
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    EnglandBritish88167500001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    DAVIS, John Terence
    Greenacres 9 Beverley Road
    Market Weighton
    YO4 3JN York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Greenacres 9 Beverley Road
    Market Weighton
    YO4 3JN York
    North Yorkshire
    British44635630002
    FAIREY, Michael Craig
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    Administrateur
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish113317640001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    GARTON, Peter Stuart
    11 Church Street
    Anlaby
    HU10 7DG Hull
    North Humberside
    Administrateur
    11 Church Street
    Anlaby
    HU10 7DG Hull
    North Humberside
    British36207450001
    HEWITT, David Dennis
    18 Melton Road
    North Ferriby
    HU14 3ET Hull
    East Yorkshire
    Administrateur
    18 Melton Road
    North Ferriby
    HU14 3ET Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish76597830001
    HUNT, Peter Charles
    14 The Spinney
    Swanland
    HU14 3RD North Ferriby
    North Humberside
    Administrateur
    14 The Spinney
    Swanland
    HU14 3RD North Ferriby
    North Humberside
    British22690310001
    JEFFREY, John Ewan
    6 Kilmany Road
    Wormit
    DD6 8PF Newport On Tay
    Fife
    Administrateur
    6 Kilmany Road
    Wormit
    DD6 8PF Newport On Tay
    Fife
    British23890370001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    TAYLOR, Keith Edwin
    Church View Ivy Lane
    Hedon
    HU12 8BL Hull
    North Humberside
    Administrateur
    Church View Ivy Lane
    Hedon
    HU12 8BL Hull
    North Humberside
    United KingdomBritish16866320001
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Administrateur
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330003
    WILDE, John Henry
    5 Wilkesley Cottages
    Wilkesley
    SY13 4BA Whitchurch
    Administrateur
    5 Wilkesley Cottages
    Wilkesley
    SY13 4BA Whitchurch
    British36207460002

    AIM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 oct. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession and charge
    Créé le 19 oct. 2006
    Livré le 02 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Keyman assignation
    Créé le 04 juil. 1996
    Livré le 17 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no. 3967240 dated 29TH may 1996 with scottish equitable for the sum of £200,000 on the life of stephen taylor parker together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of life policy
    Créé le 29 sept. 1994
    Livré le 07 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy number 3741771 dated 21.3.94 for the sum of £200,000 and all bonuses and benefits and all rights title and interest present and future therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 avr. 1994
    Livré le 17 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and in terms of the £350,000 10% redeemable secured loan stock 1994 of the company created on 21ST december 1993
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Melville Street Investments PLC Limitedas Agent for Itself and British Linen Securities
    Transactions
    • 17 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of offset.
    Créé le 20 juin 1990
    Livré le 02 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from aim LTD aim commercial systems LTD, aim supplies and print LTD,aim professional systems LTD training services LTD aim retail systems LTD aim communications services LTD aim law data LTD aim finance LTD to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums of the company on any account held by the bank.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 05 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 août 1987
    Livré le 27 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Govenor & Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 05 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AIM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2014Commencement of winding up
    05 nov. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0