AIM HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AIM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02120855 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AIM HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AIM HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AIM HOLDINGS LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour AIM HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | GAZ2 | |||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2013 | 12 pages | AA | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
Nomination de Denise Williams en tant que secrétaire | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Ms Vinodka Murria en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kerry Crompton en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Barbara Ann Firth en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Preedy en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul David Gibson en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* le 25 mars 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2013 au 28 févr. 2013 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Ian Preedy le 15 août 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Ian Preedy le 16 août 2012 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Richard Ian Preedy en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kerry Jane Crompton le 16 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de AIM HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Denise | Secrétaire | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176952300001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| BOOTH, Michael David | Secrétaire | The Coach House Humber Road HU14 3DW North Ferriby East Yorkshire | British | 88167500001 | ||||||
| CHALLINGER, Sara | Secrétaire | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| FAIREY, Michael Craig | Secrétaire | 4 Manor Croft Bishop Wilton YO42 1TG York North Yorkshire | British | 113317640001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Secrétaire | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | 73934790001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Secrétaire | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
| ANDERSON, James Douglas | Administrateur | 4 Stirling Road EH5 3HY Edinburgh | United Kingdom | British | 15707300001 | |||||
| BAGAN, Helen | Administrateur | Flat 4 Spencer Court Spencer Place N1 2AX London | United Kingdom | British | 102014660001 | |||||
| BEARPARK, Richard Mosely | Administrateur | Broadfield 16 Clifford Manor Road GU4 8AG Guildford Surrey | England | British | 121373650001 | |||||
| BOOTH, Michael David | Administrateur | The Coach House Humber Road HU14 3DW North Ferriby East Yorkshire | England | British | 88167500001 | |||||
| CROMPTON, Kerry Jane | Administrateur | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | United Kingdom | British | 158261930001 | |||||
| DAVIS, John Terence | Administrateur | Greenacres 9 Beverley Road Market Weighton YO4 3JN York North Yorkshire | British | 44635630002 | ||||||
| FAIREY, Michael Craig | Administrateur | 4 Manor Croft Bishop Wilton YO42 1TG York North Yorkshire | United Kingdom | British | 113317640001 | |||||
| FIRTH, Barbara Ann | Administrateur | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | 73934790001 | |||||
| GARTON, Peter Stuart | Administrateur | 11 Church Street Anlaby HU10 7DG Hull North Humberside | British | 36207450001 | ||||||
| HEWITT, David Dennis | Administrateur | 18 Melton Road North Ferriby HU14 3ET Hull East Yorkshire | United Kingdom | British | 76597830001 | |||||
| HUNT, Peter Charles | Administrateur | 14 The Spinney Swanland HU14 3RD North Ferriby North Humberside | British | 22690310001 | ||||||
| JEFFREY, John Ewan | Administrateur | 6 Kilmany Road Wormit DD6 8PF Newport On Tay Fife | British | 23890370001 | ||||||
| LEUW, Martin Philip | Administrateur | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141644370001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Administrateur | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| PREEDY, Richard Ian | Administrateur | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 123433610003 | |||||
| RITCHIE, Alastair James | Administrateur | Mickry Lodge 56 Gamekeepers Road EH4 6LS Edinburgh Lothian | British | 38770080002 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Administrateur | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 12470210004 | |||||
| TAYLOR, Keith Edwin | Administrateur | Church View Ivy Lane Hedon HU12 8BL Hull North Humberside | United Kingdom | British | 16866320001 | |||||
| VELUSSI, Luca | Administrateur | 123 Hepworth Court 30 Gatliff Road SW1W 8QP London | United Kingdom | Italian | 113413330003 | |||||
| WILDE, John Henry | Administrateur | 5 Wilkesley Cottages Wilkesley SY13 4BA Whitchurch | British | 36207460002 |
AIM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 02 oct. 2007 Livré le 15 oct. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession and charge | Créé le 19 oct. 2006 Livré le 02 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Keyman assignation | Créé le 04 juil. 1996 Livré le 17 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Policy no. 3967240 dated 29TH may 1996 with scottish equitable for the sum of £200,000 on the life of stephen taylor parker together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation of life policy | Créé le 29 sept. 1994 Livré le 07 oct. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Policy number 3741771 dated 21.3.94 for the sum of £200,000 and all bonuses and benefits and all rights title and interest present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 avr. 1994 Livré le 17 mai 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and in terms of the £350,000 10% redeemable secured loan stock 1994 of the company created on 21ST december 1993 | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset. | Créé le 20 juin 1990 Livré le 02 juil. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from aim LTD aim commercial systems LTD, aim supplies and print LTD,aim professional systems LTD training services LTD aim retail systems LTD aim communications services LTD aim law data LTD aim finance LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All sums of the company on any account held by the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 août 1987 Livré le 27 août 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
AIM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0