AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAUTO INDEMNITY (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02121818
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    50 - 52 Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOTOR HIRE (DISS) LIMITED07 juil. 199207 juil. 1992
    MOTOR AID HIRE LIMITED10 avr. 198710 avr. 1987

    Quels sont les derniers comptes de AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2016

    État du capital au 28 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 22 Chancery Lane London WC2A 1LS

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 22 Chancery Lane London WC2A 1LS

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Robert Martin Fielding en tant que directeur le 17 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2014 au 30 juin 2015

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Quindell Court 1 Barnes Wallis Road Segensworth East Fareham Hampshire PO15 5UA England à 50 - 52 Chancery Lane London WC2A 1HL le 19 août 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Mr Kenneth John Fowlie en tant qu'administrateur le 29 mai 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Kirsten Morrison en tant que secrétaire le 29 mai 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Laurence Moorse en tant que directeur le 29 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Ian Charles Walker en tant que secrétaire le 29 mai 2015

    1 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Indemnity House Sir Frank Whittle Way Blackpool Lancashire FY4 2FB à Quindell Court 1 Barnes Wallis Road Segensworth East Fareham Hampshire PO15 5UA le 02 mars 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 janv. 2015

    État du capital au 02 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Laurence Moorse en tant qu'administrateur le 10 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Robert Martin Fielding en tant qu'administrateur le 10 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Badal Sandhu en tant que directeur le 10 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Edward Ian Charles Walker en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Ian Farrelly en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    2 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MORRISON, Kirsten
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    Secrétaire
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    198644090001
    FOWLIE, Kenneth John
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    Administrateur
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    AustraliaAustralianLawyer197320660001
    BOBBINS, Valerie Jean
    Dickleburgh Manor
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    Secrétaire
    Dickleburgh Manor
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    British3124710004
    FARRELLY, Ian
    Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    1
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    1
    Hampshire
    England
    180946780001
    HARRISON, Peter John
    Indemnity House
    Sir Frank Whittle Way
    FY4 2FB Blackpool
    Lancashire
    Secrétaire
    Indemnity House
    Sir Frank Whittle Way
    FY4 2FB Blackpool
    Lancashire
    United KingdomFinance Director98870750001
    ORME, Geoffrey Michael
    8 Grange Road
    FY8 2BN Lytham St Annes
    Lancashire
    Secrétaire
    8 Grange Road
    FY8 2BN Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishFinance Director116893470001
    WALKER, Edward Ian Charles
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    189125400001
    BOBBINS, Kenneth
    Dickleburgh Manor Norwich Road
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Dickleburgh Manor Norwich Road
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director21179050003
    BOBBINS, Valerie Jean
    Dickleburgh Manor
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Dickleburgh Manor
    Dickleburgh
    IP21 4NJ Diss
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director3124710004
    CANAVAN, Lorraine Mary
    23 Fieldens Farm Lane
    Mellor Brook
    BB2 7PD Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    23 Fieldens Farm Lane
    Mellor Brook
    BB2 7PD Blackburn
    Lancashire
    BritishHr Manager45874210002
    FIELDING, Robert Martin
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    Administrateur
    Chancery Lane
    WC2A 1HL London
    50 - 52
    England
    EnglandBritishCompany Director187535920001
    MOORSE, Laurence
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    Administrateur
    1 Barnes Wallis Road
    Segensworth East
    PO15 5UA Fareham
    Quindell Court
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director78291360003
    ORME, Geoffrey Michael
    8 Grange Road
    FY8 2BN Lytham St Annes
    Lancashire
    Administrateur
    8 Grange Road
    FY8 2BN Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director116893470001
    PALMER, Adrian Matthew
    Rotherfield Lodge
    Beacon Road
    TN6 1UQ Crowborough
    East Sussex
    Administrateur
    Rotherfield Lodge
    Beacon Road
    TN6 1UQ Crowborough
    East Sussex
    BritishChief Executive29054400004
    SANDHU, David Badal
    Indemnity House
    Sir Frank Whittle Way
    FY4 2FB Blackpool
    Lancashire
    Administrateur
    Indemnity House
    Sir Frank Whittle Way
    FY4 2FB Blackpool
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector73704510004

    AUTO INDEMNITY (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture
    Créé le 26 oct. 1991
    Livré le 07 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or colegate vehicle hire limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 ref 543C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0