J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED

J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02123521
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    J H MINET REINSURANCE BROKERS LIMITED16 nov. 198716 nov. 1987
    STANDCITE LIMITED15 avr. 198715 avr. 1987

    Quels sont les derniers comptes de J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Paul Francis Clayden en tant que directeur le 21 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 sept. 2011

    13 pages4.68

    Cessation de la nomination de Yvonne Fisher en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 sept. 2010

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de 8 Devonshire Square London EC2M 4PL le 04 oct. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 août 2010

    État du capital au 10 août 2010

    • Capital: GBP 18,118,585
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Nomination de Yvonne Jane Fisher en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Stephen Dudley Gale en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Edward Cruttwell en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Heap en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    6 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COSEC 2000 LIMITED
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Secrétaire
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    64208180001
    GALE, Stephen Dudley
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United KingdomBritish152013590001
    ASPINALL, Nicholas
    45 Southdean Gardens
    Wimbledon
    SW19 6NT London
    Secrétaire
    45 Southdean Gardens
    Wimbledon
    SW19 6NT London
    British29662910003
    PYTCHES, Andrew Martyn
    4 Shirley Road
    EN2 6SB Enfield
    Middlesex
    Secrétaire
    4 Shirley Road
    EN2 6SB Enfield
    Middlesex
    British13889860001
    BARRIE, David Philip
    Showsley Farmhouse
    Showsley
    NN12 7NR Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Showsley Farmhouse
    Showsley
    NN12 7NR Towcester
    Northamptonshire
    British14926200001
    BEGLEY, John Patrick
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British110985340001
    BUCKINGHAM, Philip
    6 Meridian Way, Amwell Way
    Great Amwell
    SG12 8DW Ware
    Administrateur
    6 Meridian Way, Amwell Way
    Great Amwell
    SG12 8DW Ware
    British82552960001
    CLAYDEN, Paul Francis
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United KingdomBritish138098080001
    CRUTTWELL, Edward Robert Charles
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    British34367480002
    DOODES, Edward John
    67 Godfrey Way
    Great Dunmow
    CM6 2SE Dunmow
    Essex
    Administrateur
    67 Godfrey Way
    Great Dunmow
    CM6 2SE Dunmow
    Essex
    British28939540001
    EDWARDS, Nicholas Steven
    The Crest Pennymead Rise
    KT24 5AL East Horsley
    Administrateur
    The Crest Pennymead Rise
    KT24 5AL East Horsley
    British28939550002
    EWEN, Rodney John
    Brasted Place Farm
    Brasted
    SE9 5AP Westerham
    Kent
    Tn16 1je
    Administrateur
    Brasted Place Farm
    Brasted
    SE9 5AP Westerham
    Kent
    Tn16 1je
    British14926220001
    FISHER, Yvonne Jane
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    England
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    England
    EnglandBritish152086390001
    FODEN-PATTINSON, Nicholas Simon
    18 Stockenchurch Street
    SW6 3TR London
    Administrateur
    18 Stockenchurch Street
    SW6 3TR London
    British3046640001
    HART, Nigel
    Vines Vines Lane
    TN11 9LT Hildenborough
    Kent
    Administrateur
    Vines Vines Lane
    TN11 9LT Hildenborough
    Kent
    British37668040001
    HARVEY, Brian John
    31 Eastwood Road
    SS9 3AJ Leigh On Sea
    Essex
    Administrateur
    31 Eastwood Road
    SS9 3AJ Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish13706550001
    HAYES, Bryan Joseph
    1 Abbotts Court Thackeray Street
    W8 4AL London
    Administrateur
    1 Abbotts Court Thackeray Street
    W8 4AL London
    Irish49014750001
    HEAP, Michael Conrad
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    Administrateur
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    British93892910002
    HILL, John Lawrence
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British663680003
    HOPE, Duncan Patrick Nicholson
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British110985300001
    HOPE, Ralph James D'Olier
    The Old Farmhouse
    Slugwash Lane
    RH17 7RQ Wivelsfield Green
    West Sussex
    Administrateur
    The Old Farmhouse
    Slugwash Lane
    RH17 7RQ Wivelsfield Green
    West Sussex
    United KingdomBritish35654410001
    HVIDSTEN, Mark Trygue
    300 East 56 Street
    Apartment 20a
    NY 10022 New York
    Administrateur
    300 East 56 Street
    Apartment 20a
    NY 10022 New York
    South African28868160003
    LAWSON, David John
    Chimneys Oakcroft Road
    KT14 6JH West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Chimneys Oakcroft Road
    KT14 6JH West Byfleet
    Surrey
    British54169840001
    MELLALIEU, Kevin John
    8 Grange Road
    Hazlemere
    HP15 7QZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    8 Grange Road
    Hazlemere
    HP15 7QZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British68083580001
    ORAM, William John
    8 Devonshire Square
    EC4M 2PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC4M 2PL London
    United KingdomOther98212820001
    PARMENTER, Michael Peter
    37 Hawkwell Park Drive
    Hawkwell
    SS5 4HA Hockley
    Essex
    Administrateur
    37 Hawkwell Park Drive
    Hawkwell
    SS5 4HA Hockley
    Essex
    British58496290001
    PHIPPS, Roger Charles Jacklin
    Middle House Shurlock Row
    RG10 0PS Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Middle House Shurlock Row
    RG10 0PS Reading
    Berkshire
    British28939570001
    PYTCHES, Andrew Martyn
    4 Shirley Road
    EN2 6SB Enfield
    Middlesex
    Administrateur
    4 Shirley Road
    EN2 6SB Enfield
    Middlesex
    British13889860001
    ROSSOR, Michael Keith
    72 Links Way
    Eden Park
    BR3 3DQ Beckenham
    Kent
    Administrateur
    72 Links Way
    Eden Park
    BR3 3DQ Beckenham
    Kent
    British55457000001
    WALL, David Neil
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    Administrateur
    8 Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    British25408090002
    WOODHOUSE, Paul Richard
    The Grange
    Chipstead Lane
    TN13 2RD Chipstead
    Kent
    Administrateur
    The Grange
    Chipstead Lane
    TN13 2RD Chipstead
    Kent
    EnglandBritish82942540001

    J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of variation
    Créé le 17 févr. 1997
    Livré le 27 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All costs expenses obligations and other liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the security and trust deed and any loan or overdraft facility (as defined)
    Brèves mentions
    All moneys (including brokerage )for the time beign standing to the credit of or pursuant to the bylelaw required to be paid into an insurance broking account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's as Trustee for Approved Banks (As Defined)
    Transactions
    • 27 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 17 juin 1994
    Livré le 06 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an indemnity dated 17TH june 1994 and this charge
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in all "designated securities" (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge
    Créé le 17 juin 1994
    Livré le 06 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an indemnity dated 17TH june 1994 (as defined)
    Brèves mentions
    All monies held by the bank at its lloyd's building branch on acct/no.14877007.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security and trust deed.
    Créé le 17 sept. 1990
    Livré le 27 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyd's brokers byelaw (nos of 1988) ("the byelaw") see form 345 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds (A Statutory Corporation)
    Transactions
    • 27 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    J H MINET REINSURANCE SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 sept. 2010Commencement of winding up
    26 déc. 2012Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Robert
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    practitioner
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0