MCC LEASING (NO.24) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMCC LEASING (NO.24) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02127066
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MCC LEASING (NO.24) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MCC LEASING (NO.24) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MCC LEASING (NO.24) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MCC LEASING (NO.24) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MCC LEASING (NO.24) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 Churchill Place London E14 5HP à Barclays Group Archives Dallimore Road Manchester M23 9VA

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 16 juil. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 juil. 2015

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Mohammed Akram en tant que directeur le 13 mars 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 sept. 2014

    État du capital au 16 sept. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Jonathan Mark Huckle en tant que directeur le 29 août 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    27 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2013 au 31 mars 2014

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Hazel Watson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Gavin John Simpson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Jonathan Mark Huckle en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Duncan Rowberry en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de MCC LEASING (NO.24) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secrétaire
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secrétaire
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Administrateur
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HUCKLE, Jonathan Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish163223760001
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Administrateur
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    MCC LEASING (NO.24) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of covenants
    Créé le 27 sept. 2005
    Livré le 13 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the ship and all its earnings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nib Capital Bank N.V
    Transactions
    • 13 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage of a ship
    Créé le 27 sept. 2005
    Livré le 13 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty-fourth (64/64TH) shares in the british registered ship M.v hatsu shine hull number 1265 official number 910289. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nib Capital Bank N.V
    Transactions
    • 13 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Owner proceeds account charge
    Créé le 21 juin 2004
    Livré le 06 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the sub-charterer, the guarantor or any other person, the company or any other person to the company, the charterer and/or any other member of the charteres group, any other member of the owners group to any one or more of the chartere, the agent, the receivable purchases, strip lc bank, the sub-charterer under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest present and future in respect of the owner proceeds account together with any certificates of deposit, deposit receipts or other instruments or securities relating to the owner proceeds account.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nibn Capital Bank N.V., in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Itself and the Other Beneficiaries
    Transactions
    • 06 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Hatsu general assignment
    Créé le 21 juin 2004
    Livré le 06 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the sub-charterer, the guarantor or any other person, the company or any other person to the company, the charterer and/or any other member of the charteres group, any other member of the owners group to any one or more of the chartere, the agent, the receivable purchases, strip lc bank, the sub-charterer under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title benefit and interest present and future actual and contingent in to under and in respect of the insurance's and any requisition compensation.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nibn Capital Bank N.V., in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Itself and the Other Beneficiaries
    Transactions
    • 06 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenants
    Créé le 21 janv. 2003
    Livré le 23 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the vessel (M.V."hatsu excel",mhi e-type 6,332 teu container,hull no 1253) with all her earnings thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale
    Transactions
    • 23 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 21 janv. 2003
    Livré le 23 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the british registered ship M.V."hatsu ethic" with official no 906633 and all her equipment thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale
    Transactions
    • 23 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    An insurance assignment
    Créé le 12 déc. 2002
    Livré le 23 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The rights, title, benefit and interest in and to the insurances.
    Personnes ayant droit
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A charge over account
    Créé le 12 déc. 2002
    Livré le 23 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The rights, title, benefit and interest in and to the charged account.
    Personnes ayant droit
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 06 juin 2002
    Livré le 18 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sixty-four (64/64TH) shares in the british registered ship M.V. "hatsu excel" with official number 905520 and in her equipment and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 18 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over account
    Créé le 04 juin 2002
    Livré le 18 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's rights title and interest in and to the charged account by way of first fixed charge including without limitation any and all amounts deposited therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 18 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenants
    Créé le 04 juin 2002
    Livré le 18 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's rights title and interest in and to the vessel and all her earnings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 18 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    An insurance assignment
    Créé le 04 juin 2002
    Livré le 18 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's rights title and interest in and to the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hamburgische Landesbank-Girozentrale-(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 18 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    MCC LEASING (NO.24) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 juil. 2015Commencement of winding up
    04 févr. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0