ARRIVA CHESHIRE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ARRIVA CHESHIRE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02127702 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ARRIVA CHESHIRE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ARRIVA CHESHIRE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour ARRIVA CHESHIRE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP le 14 sept. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Kenneth Mcintyre Carlaw en tant qu'administrateur le 28 août 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Martin Stone en tant que directeur le 28 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Anthony Bowler en tant que directeur le 28 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 26 mai 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Malcolm Gilkerson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Malcolm Gilkerson le 05 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Anthony Bowler le 05 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Martin Stone le 05 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 05 janv. 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ARRIVA CHESHIRE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Secrétaire | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Administrateur | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village | England | British | 161250030001 | |||||
| FAWCETT, Pauline | Secrétaire | Oaklands Warrington Road Mere WA16 0TF Knutsford Cheshire | British | 4159290001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Secrétaire | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Secrétaire | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BAYFIELD, Stephen | Administrateur | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| CLAYTON, Stephen John | Administrateur | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | 46866840005 | |||||
| FAWCETT, Simon Anthony | Administrateur | Blair House Legh Road WA16 8LP Knutsford Cheshire | British | 7273070001 | ||||||
| GILKERSON, Malcolm | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | 46793270001 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Administrateur | 18 Maplewell Road Woodhouse Eaves LE12 8QZ Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 21961900002 | |||||
| JONES, Michael Adrian | Administrateur | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Administrateur | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Administrateur | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| RAVEN, Garry Stuart | Administrateur | 38 Daleside Thornhill Edge WF12 0PJ Dewsbury West Yorkshire | British | 64406500001 | ||||||
| RAY, John Alfred | Administrateur | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| STONE, Philip Martin | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | England | British | 69200640003 | |||||
| STONE, Philip Martin | Administrateur | 21 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | 69200640003 | |||||
| WALLACE, Neale Howard | Administrateur | 17 Lincoln Road Wrockwardine Wood TF2 6LF Telford Shropshire | British | 43081660001 | ||||||
| WATT, Gordon George | Administrateur | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | England | British | 67622780002 | |||||
| WILLIAMS, Dawson Thomas | Administrateur | Chately Wood House Rockford BH24 3LZ Ringwood Hampshire | British | 2719600006 |
ARRIVA CHESHIRE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Créé le 15 juin 1995 Livré le 20 juin 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement,any interest rate agreement or any other grant or security under any of the security documents (as defined therein) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Credit agreement | Créé le 25 mai 1993 Livré le 03 juin 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £71,365.02 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the paper apart to form 395 see form 395 M139C for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattels mortgage | Créé le 18 janv. 1993 Livré le 19 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All and singular the chattels plant machinery and as described 1 new mercedes benz 709D chassis cab fitted with dormobile body chassis no:669003-2N-0048165,registration no:K880 udb or any part thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 10 juil. 1987 Livré le 15 juil. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
ARRIVA CHESHIRE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0