HARNESSFLEX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARNESSFLEX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02130654
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARNESSFLEX LIMITED ?

    • fabrication d'appareils et d'équipements télégraphiques et téléphoniques (26301) / Industries manufacturières
    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HARNESSFLEX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Kpmg Llp 8
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HARNESSFLEX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour HARNESSFLEX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 avr. 2013

    3 pages4.68
    A28DM2ZT

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71
    A2767A4I

    Changement d'adresse du siège social de 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH United Kingdom le 28 déc. 2012

    2 pagesAD01
    A1O7CUN7

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70
    A1O7CUNF

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution :- "In Specie"
    1 pagesLIQ MISC RES
    A1O7CUMZ

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 déc. 2012

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600
    A1O7CUMB

    legacy

    3 pagesMG02
    A1M7HQKB

    legacy

    3 pagesMG02
    A1M7HQK3

    legacy

    3 pagesMG02
    A1M7HQJV

    legacy

    3 pagesMG02
    A1M7HQJN

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Fabrice Jean-Pierre Van Belle le 12 nov. 2012

    2 pagesCH01
    X1LMBR6X

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA
    A1KPLFEH

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 sept. 2012

    État du capital au 07 sept. 2012

    • Capital: GBP 50,000
    SH01
    X1GYN3GO

    Cessation de la nomination de Duncan Alexander Mckinlay en tant que directeur le 30 août 2011

    1 pagesTM01
    XS6WOXO0

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    XD99QWCQ

    Modification des coordonnées de l'administrateur Duncan Alexander Mckinlay le 06 oct. 2010

    2 pagesCH01
    XZDPFP68

    Nomination de Mr Fabrice Van Belle en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    XNBBHO8J

    Période comptable actuelle prolongée du 31 juil. 2011 au 31 déc. 2011

    1 pagesAA01
    XNBCNO8Q

    Nomination de Mr William Edward Weaver, Jr en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    XNB59O85

    Nomination de Mr William David Smith, Jr en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    XNAYJO87

    Nomination de Mr William David Smith, Jr en tant que secrétaire

    1 pagesAP03
    XNAMYO8A

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 30/09/2010
    RES13

    Changement d'adresse du siège social de Cmg House Station Road Coleshill Birmingham West Midlands B46 1HT le 06 oct. 2010

    1 pagesAD01
    XJSKCO0S

    Qui sont les dirigeants de HARNESSFLEX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, JR, William David
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    C/O Kpmg Llp 8
    Secrétaire
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    C/O Kpmg Llp 8
    154906290001
    SMITH, JR, William David
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    C/O Kpmg Llp 8
    Administrateur
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    C/O Kpmg Llp 8
    UsaUsaDirector154905920001
    VAN BELLE, Fabrice Jean-Pierre
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    C/O Kpmg Llp 8
    Administrateur
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    C/O Kpmg Llp 8
    BelgiumBelgianDirector162211840002
    WEAVER, William Edward
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    C/O Kpmg Llp 8
    Administrateur
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    C/O Kpmg Llp 8
    United StatesUsaDirector146203060001
    BURDETT, Neil Robert
    5 Oak House Parson Street
    Hendon
    NW4 1QJ London
    Secrétaire
    5 Oak House Parson Street
    Hendon
    NW4 1QJ London
    British188620002
    CLEWS, Simon Paul
    25 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    25 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    BritishAccountant45290840004
    DALE, Stephen Bernard
    52 Oakfield Drive
    B45 8AH Rednal
    Birmingham
    Secrétaire
    52 Oakfield Drive
    B45 8AH Rednal
    Birmingham
    BritishCompany Secretary73665890001
    DIAMOND, Steven John
    41 Aintree Drive
    Downend
    BS16 6SY Bristol
    Avon
    Secrétaire
    41 Aintree Drive
    Downend
    BS16 6SY Bristol
    Avon
    BritishFinance Director44344270001
    LARAWAY, Stephen
    12 Trustin Crescent
    B92 9QQ Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    12 Trustin Crescent
    B92 9QQ Solihull
    West Midlands
    British76616870001
    SMITH, Alan
    37 Pattison Road
    NW2 2HL London
    Secrétaire
    37 Pattison Road
    NW2 2HL London
    British32394380001
    VITTY, Martyn John
    Ardens
    Grafton
    B49 6DT Alcester
    Ardenlaw
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ardens
    Grafton
    B49 6DT Alcester
    Ardenlaw
    Warwickshire
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant293401400001
    CLEWS, Simon Paul
    25 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    25 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    BritishAccountant45290840004
    DAVIS, Ivor Stephen
    Meadow Cottage
    Sunset Lane
    RH20 2NY West Chiltington
    West Sussex
    Administrateur
    Meadow Cottage
    Sunset Lane
    RH20 2NY West Chiltington
    West Sussex
    EnglandBritishAccountant59183650001
    DIAMOND, Steven John
    41 Aintree Drive
    Downend
    BS16 6SY Bristol
    Avon
    Administrateur
    41 Aintree Drive
    Downend
    BS16 6SY Bristol
    Avon
    EnglandBritishDirector44344270001
    HAYES, Paul Andrew
    3 Normanton Road
    Packington
    LE65 1WS Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Administrateur
    3 Normanton Road
    Packington
    LE65 1WS Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishAccountant47679660002
    HILL, David James
    7 Brook End Drive
    Henley In Arden
    B95 5JA Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    7 Brook End Drive
    Henley In Arden
    B95 5JA Solihull
    West Midlands
    BritishDirector18357900001
    HUTCHINSON, Shirley Anne
    78 Worthington Road
    Fradley
    WS13 8PG Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    78 Worthington Road
    Fradley
    WS13 8PG Lichfield
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant70944860002
    LARAWAY, Stephen
    2 Nesfield Grove
    Hampton In Arden
    B92 0BQ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    2 Nesfield Grove
    Hampton In Arden
    B92 0BQ Solihull
    West Midlands
    BritishDirector76616870002
    LARAWAY, Stephen
    12 Trustin Crescent
    B92 9QQ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    12 Trustin Crescent
    B92 9QQ Solihull
    West Midlands
    BritishDirector76616870001
    MCKINLAY, Duncan Alexander
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    United Kingdom
    Administrateur
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director189661060001
    POULTON, Adrian Roger
    Church Meadow
    Church Lane, Lapworth
    B94 5NU Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Church Meadow
    Church Lane, Lapworth
    B94 5NU Solihull
    West Midlands
    EnglandEnglishDirector66370240001
    ROBERTS, Colin Allen
    73 Hither Green Lane
    Abbey Park
    B98 9BN Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    73 Hither Green Lane
    Abbey Park
    B98 9BN Redditch
    Worcestershire
    BritishGeneral Manager26409320002
    RUTTER, Lee Francis
    3 Lydiard Green
    Lydiard Millicent
    SN5 3LP Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    3 Lydiard Green
    Lydiard Millicent
    SN5 3LP Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector114243050001
    SANDERS, Robert Braith Charles
    4 Paddock Way
    SO24 9PN Alresford
    Hampshire
    Administrateur
    4 Paddock Way
    SO24 9PN Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant70944840001
    SARGENT, Kevin
    Rowgardens
    Horsham Road
    GU6 8EJ Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Rowgardens
    Horsham Road
    GU6 8EJ Cranleigh
    Surrey
    BritishAccountant81766730002
    SPENCER, David Malcolm
    The Old Church House
    Church Road
    SL5 0NL Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Church House
    Church Road
    SL5 0NL Sunningdale
    Berkshire
    BritishDirector70572490001
    VITTY, Martyn John
    Ardens
    Grafton
    B49 6DT Alcester
    Ardenlaw
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ardens
    Grafton
    B49 6DT Alcester
    Ardenlaw
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant293401400001

    HARNESSFLEX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Intellectual property rights charge
    Créé le 04 janv. 2007
    Livré le 17 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The secured property being the patents the trade marks the designs the copyright works the goodwill the physical materials the right to ask for and recover damages. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries) (the Mezzaninesecurity Trustee)
    Transactions
    • 17 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Intellectual property rights charge
    Créé le 04 janv. 2007
    Livré le 17 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The secured property being the patents the trade marks the designs the copyright works the goodwill the physical materials the right to ask for and recover damages. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries) (the Securitytrustee)
    Transactions
    • 17 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 04 janv. 2007
    Livré le 17 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries) (the Securitytrustee)
    Transactions
    • 17 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 04 janv. 2007
    Livré le 17 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries) (the Mezzaninesecurity Trustee)
    Transactions
    • 17 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2006
    Livré le 14 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 14 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 2004
    Livré le 23 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations due or to become due from the company to the chargee (in its capacity as security agent for the beneficiaries) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 déc. 2002
    Livré le 12 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting as security agent and trustee for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizuho Corporate Bank, LTD.
    Transactions
    • 12 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HARNESSFLEX LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 déc. 2012Commencement of winding up
    03 août 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0