COMPELSOURCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMPELSOURCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02133193
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMPELSOURCE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe COMPELSOURCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    James House
    Warwick Road
    B11 2LE Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMPELSOURCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COMPELSERVE PLC16 août 199916 août 1999
    COMPEL PLC07 sept. 199407 sept. 1994
    COMPEL PLC30 sept. 198730 sept. 1987
    ISSUESECTOR PUBLIC LIMITED COMPANY20 mai 198720 mai 1987

    Quels sont les derniers comptes de COMPELSOURCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour COMPELSOURCE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour COMPELSOURCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    GAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Statuts

    16 pagesMEM/ARTS

    État du capital après une attribution d'actions au 07 mars 2014

    • Capital: GBP 13,512,491.00
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sir Peter Rigby le 14 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Paul Rigby le 14 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2008

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de COMPELSOURCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RIGBY, Peter, Sir
    James House
    Warwick Road
    B11 2LE Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    James House
    Warwick Road
    B11 2LE Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish15654920006
    RIGBY, Steven Paul
    James House
    Warwick Road
    B11 2LE Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    James House
    Warwick Road
    B11 2LE Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish41996820011
    GILPIN, Nigel Peter
    172 Widney Lane
    B91 3LH Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    172 Widney Lane
    B91 3LH Solihull
    West Midlands
    British42299200003
    GOSSAGE, Neal Trevor
    20 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    Secrétaire
    20 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    British79300420001
    HOSKING, Jeffrey Francis
    231 Waldegrave Road
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    231 Waldegrave Road
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British48462320001
    LEE, Andrew Julian
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    British17829780002
    LEE, Andrew Julian
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    British17829780002
    MONKS, Terence John
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    British80344460001
    RIGBY, James Peter
    The Bell House
    Old Warwick Road
    CV35 7BT Rowington
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Bell House
    Old Warwick Road
    CV35 7BT Rowington
    Warwickshire
    British88633720001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British12470210003
    STOCKLEY, Darren
    20 Waters End
    Stotfold
    SG5 4QA Hitchin
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Waters End
    Stotfold
    SG5 4QA Hitchin
    Hertfordshire
    British61712020002
    BELL, Colin John Rayner
    1 Gorselands Close
    KT14 6PU West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    1 Gorselands Close
    KT14 6PU West Byfleet
    Surrey
    British49813320001
    BROUGH, Geoffrey
    Flat 1 Brondesbury Villas
    NW6 6AH London
    Administrateur
    Flat 1 Brondesbury Villas
    NW6 6AH London
    British17829810001
    CALLE, David Graeme
    30 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Wewyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    30 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Wewyn
    Hertfordshire
    British49813230002
    COX, Anthony
    9 Bloomfield Drive
    RG12 2JW Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    9 Bloomfield Drive
    RG12 2JW Bracknell
    Berkshire
    British76980810001
    DAVIS, Neville
    Manyons Church Lane
    Barkway
    SG8 8EJ Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Manyons Church Lane
    Barkway
    SG8 8EJ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish17829820001
    DEAN, Paul
    2 Abbots Barn
    Vale Royal Courtyard Whitegate
    CW8 2BA Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    2 Abbots Barn
    Vale Royal Courtyard Whitegate
    CW8 2BA Northwich
    Cheshire
    British49812960002
    EVANS, Robert Ivor
    5 Curleys
    CM17 0JG Old Harlow
    Essex
    Administrateur
    5 Curleys
    CM17 0JG Old Harlow
    Essex
    British49813400001
    FORBES, Robert Gordon
    7 Woodville Place
    SG14 3NX Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 Woodville Place
    SG14 3NX Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish50248110002
    HOSKING, Jeffrey Francis
    231 Waldegrave Road
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    231 Waldegrave Road
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British48462320001
    HOWLING, Mark Ian
    7 Sharmans Close
    AL6 0AR Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 Sharmans Close
    AL6 0AR Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish71889290001
    JOSS, William Alexander
    Cherry Tree Cottage
    Newbottle
    OX17 3DD Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Cherry Tree Cottage
    Newbottle
    OX17 3DD Banbury
    Oxfordshire
    British72152610001
    KEMP, John Arthur
    20 Mays Way
    Potterspury
    NN12 7PP Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    20 Mays Way
    Potterspury
    NN12 7PP Towcester
    Northamptonshire
    British9281920001
    KEMP, John Arthur
    20 Mays Way
    Potterspury
    NN12 7PP Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    20 Mays Way
    Potterspury
    NN12 7PP Towcester
    Northamptonshire
    British9281920001
    KETTERIDGE, Mark Patrick
    64 Compton Avenue
    BH14 8PY Poole
    Dorset
    Administrateur
    64 Compton Avenue
    BH14 8PY Poole
    Dorset
    British60014860001
    LEE, Andrew Julian
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    British17829780002
    MILLER, Ross Charles
    Primrose Farm
    Hagg Lane Dunnington
    YO19 5PE York
    Yorkshire
    Administrateur
    Primrose Farm
    Hagg Lane Dunnington
    YO19 5PE York
    Yorkshire
    EnglandBritish84739210001
    PRICE, Keith Leonard
    39 Sparrow Drive
    SG2 9FB Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    39 Sparrow Drive
    SG2 9FB Stevenage
    Hertfordshire
    British70306890002
    ROBERTS, Neal Anthony
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish12470210003
    STOCKLEY, Darren
    20 Waters End
    Stotfold
    SG5 4QA Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    20 Waters End
    Stotfold
    SG5 4QA Hitchin
    Hertfordshire
    British61712020002
    TOWELL, Gordon James
    Moor Hall Cottage
    Moor Green Ardeley
    SG2 7AT Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    Moor Hall Cottage
    Moor Green Ardeley
    SG2 7AT Stevenage
    Hertfordshire
    British78743090002
    YOUNG, Gary Stuart
    244 Clewer Hill Road
    SL4 4DY Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    244 Clewer Hill Road
    SL4 4DY Windsor
    Berkshire
    Canadian65016830001

    COMPELSOURCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture deed
    Créé le 08 janv. 1999
    Livré le 15 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 03 août 1992
    Livré le 10 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transactions
    • 10 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 03 août 1992
    Livré le 07 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and/or compel group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 07 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 20 août 1991
    Livré le 31 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £73063-28 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All its right, title & interest in & to all sums payable under the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 31 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 29 sept. 1987
    Livré le 02 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 20 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    COMPELSOURCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 mars 2014Commencement of winding up
    08 août 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0