FESTIVAL CITY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFESTIVAL CITY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02136268
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FESTIVAL CITY LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe FESTIVAL CITY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1st Floor The Outset
    Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FESTIVAL CITY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    POLITEWONDER LIMITED01 juin 198701 juin 1987

    Quels sont les derniers comptes de FESTIVAL CITY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour FESTIVAL CITY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 janv. 2021

    10 pagesLIQ03

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Changement d'adresse du siège social de 17 King Street Knutsford Cheshire WA16 6DW England à 1st Floor the Outset Sankey Street Warrington WA1 1NN le 04 févr. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 janv. 2020

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 17 août 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2018

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 130 Buxton Road Stockport Cheshire SK2 6PL à 17 King Street Knutsford Cheshire WA16 6DW le 17 nov. 2019

    1 pagesAD01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Notification de Linda Joan Phillips en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 nov. 2018

    2 pagesPSC01

    Nomination de Mrs Linda Joan Phillips en tant qu'administrateur le 03 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC04

    Cessation de la nomination de Charles David Phillips en tant que directeur le 16 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles David Phillips en tant que secrétaire le 16 nov. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de Charles David Phillips en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 nov. 2018

    1 pagesPSC07

    Nomination de Mrs Linda Joan Phillips en tant que secrétaire le 02 avr. 2019

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 17 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2017

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Linda Joan Phillips en tant que directeur le 30 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de FESTIVAL CITY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PHILLIPS, Linda Joan
    11, Poplar Avenue
    L23 7ST Crosby
    11,Poplar Avenue
    Merseyside
    United Kingdom
    Secrétaire
    11, Poplar Avenue
    L23 7ST Crosby
    11,Poplar Avenue
    Merseyside
    United Kingdom
    257287560001
    PHILLIPS, Linda Joan
    11, Poplar Avenue
    L23 7ST Crosby
    11, Poplar Avenue
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    11, Poplar Avenue
    L23 7ST Crosby
    11, Poplar Avenue
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish257364400001
    PHILLIPS, Charles David
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    England
    178390180001
    PHILLIPS, Charles David
    Yew Tree House
    Free Green Lane
    WA16 9PS Lower Peover
    Cheshire
    Secrétaire
    Yew Tree House
    Free Green Lane
    WA16 9PS Lower Peover
    Cheshire
    British34424750002
    PHILLIPS, Josephine Mary
    Yew Tree House
    Free Green Lane, Lower Peover
    WA16 9PS Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    Yew Tree House
    Free Green Lane, Lower Peover
    WA16 9PS Knutsford
    Cheshire
    British67372980003
    PHILLIPS, Linda Joan
    11 Poplar Avenue
    Crosby
    L23 2ST Liverpool
    Secrétaire
    11 Poplar Avenue
    Crosby
    L23 2ST Liverpool
    British17672250001
    R S NOMINEES LIMITED
    Didsbury House
    748 Wilmslow Road Didsbury
    M20 2DW Manchester
    1st Floor
    Secrétaire
    Didsbury House
    748 Wilmslow Road Didsbury
    M20 2DW Manchester
    1st Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3114059
    52646340002
    BIRCH, George Henry Edward
    12 West Orchard Lane
    Fazakerley
    L9 9EF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    12 West Orchard Lane
    Fazakerley
    L9 9EF Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish30216650003
    PHILLIPS, Charles David
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    England
    EnglandBritish207826790001
    PHILLIPS, Charles David
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34424750003
    PHILLIPS, Linda Joan
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish17672250002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FESTIVAL CITY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Linda Joan Phillips
    Poplar Avenue
    L23 2ST Liverpool
    11,Poplar Avenue
    England
    17 nov. 2018
    Poplar Avenue
    L23 2ST Liverpool
    11,Poplar Avenue
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mr Charles David Phillips
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    01 juin 2016
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    FESTIVAL CITY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 19 mai 2016
    Livré le 24 mai 2016
    En cours
    Brève description
    37 and 39 queens road, formby, merseyside L37 2HG.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Suzanne Brown
    • Property Finance Consultants Limited
    Transactions
    • 24 mai 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 août 2013
    Livré le 21 août 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 21 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 août 2013
    Livré le 21 août 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H property k/a 37-39 queens road formby t/nos MS57418 and MS252250. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 21 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 13 août 2007
    Livré le 22 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    37-39 queens road formby merseyside t/n MS252250 and MS57418. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2007
    Livré le 06 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 28 sept. 2001
    Livré le 04 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £191,250.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the provisions of the charge deed
    Brèves mentions
    The freehold property known as 132, 134 and 134A turves road, cheadle, hulme, cheshire, and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge of securities (UK)
    Créé le 06 juil. 2001
    Livré le 20 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from tatton property investments (liverpool) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) which are from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company to the bank together with all income derived from and rights attaching to the same.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 26 avr. 2000
    Livré le 05 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • West Bromwich Building Society
    Transactions
    • 05 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 26 avr. 2000
    Livré le 05 mai 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The right to receive all payments reserved as rent under the lease dated 30 april 1993. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • West Bromwich Building Society
    Transactions
    • 05 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Commercial mortgage
    Créé le 26 avr. 2000
    Livré le 05 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a 22 high street stone staffordshire t/no SF413383 and all buildings fixtures plant and machinery..by way of first fixed charge all the goodwill of the business the full benefit of all licences consents permissions and agreements.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • West Bromwich Building Society
    Transactions
    • 05 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 mars 1999
    Livré le 13 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £145,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    22 high st,stone,staffordshire; sf 259197.
    Personnes ayant droit
    • Linda Joan Phillips
    Transactions
    • 13 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 13 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £80,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    27 chapel lane formby merseyside.
    Personnes ayant droit
    • Linda Joan Phillips
    Transactions
    • 13 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 09 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 09 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rental assignment
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 02 juin 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest of the company in and to all rent, licence fees or other sums received by the company from any tenant or licensee of the property k/a 27 chapel lane formby t/nos.MS384772 and MS363921. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 02 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Commercial mortgage
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 02 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    27 chapel lane formby t/nos.MS384772 and MS363921 together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery. The benefit of all guarantees indemnities rent deposits. By way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights. Assigns the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 02 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rental assignment
    Créé le 02 mars 1998
    Livré le 04 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rent, licence fees or other sums of money now or at any time received or recoverable by the company from any any tenant or licensee of the property k/a 48 king street knutsford or any part thereof.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 04 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Commercial mortgage
    Créé le 02 mars 1998
    Livré le 04 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 48 king street knutford together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery. The benefit of all guarantees indemnities rent deposits. By way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights. Assigns the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 04 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage and general charge
    Créé le 25 janv. 1995
    Livré le 07 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £435,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H property k/a 27 chapel lane, formby, merseyside. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Linda Joan Phillips
    Transactions
    • 07 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FESTIVAL CITY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 janv. 2020Commencement of winding up
    28 nov. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Peter Fisher
    Parkin S Booth & Co 1st Floor The Outset
    (Bank Quay House) Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Cheshire
    practitioner
    Parkin S Booth & Co 1st Floor The Outset
    (Bank Quay House) Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Cheshire
    Ian Cathrell Brown
    1st Floor The Outset (Bank Quay House) Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Cheshire
    practitioner
    1st Floor The Outset (Bank Quay House) Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Cheshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0