BRYANT HOMES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BRYANT HOMES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02136271 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRYANT HOMES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRYANT HOMES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BRYANT HOMES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 22 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BRYANT HOMES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Sara Hollowell en tant qu'administrateur le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que directeur le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Sara Hollowell en tant que secrétaire le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Michael Andrew Lonnon en tant que directeur le 09 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant qu'administrateur le 09 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que directeur le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant qu'administrateur le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que directeur le 11 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant qu'administrateur le 11 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que secrétaire le 11 mai 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 11 mai 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 6 pages | AA | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 pages | AD03 | ||
Qui sont les dirigeants de BRYANT HOMES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOWELL, Sara | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 340868120001 | |||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 308911230001 | |||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 147112780001 | |||||||
| CANTY, Jennifer | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 322291650001 | |||||||
| CARR, Peter Anthony | Secrétaire | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| DE FEO, Caterina | Secrétaire | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||
| DENNISON, John Patrick Edmund | Secrétaire | 21 Linton Avenue B91 3NN Solihull West Midlands | British | 14008270001 | ||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Secrétaire | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219901720001 | |||||||
| JORDAN, James John | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 166036960001 | |||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secrétaire | 78 Long Drive HA4 0HP South Ruislip Middlesex | British | 34521340004 | ||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Administrateur | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | England | British | 193735640001 | |||||
| ANDREW, Peter Robert | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| BRYANT, Alan Christopher | Administrateur | Old School House Saintbury WR12 7PX Broadway Worcestershire | British | 1910400001 | ||||||
| CANTY, Jennifer | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CARTER, John David William | Administrateur | Low Field House 24 Low Field Lane, Staveley HG5 9LB Knaresborough North Yorkshire | England | British | 86948230001 | |||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| DALTON, Michael | Administrateur | 92 The Mount YO24 1AR York North Yorkshire | British | 92440180001 | ||||||
| DENNISON, John Patrick Edmund | Administrateur | 21 Linton Avenue B91 3NN Solihull West Midlands | British | 14008270001 | ||||||
| GABB, Colin | Administrateur | 23 Little Fryth RG40 3RN Wokingham Berkshire | England | British | 87309290001 | |||||
| GEORGE, Brian Victor | Administrateur | Wethersfield Wood Street Bushley Green GL20 6JA Tewkesbury Gloucestershire | British | 34400710001 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||
| KNIGHT, David Jonathan | Administrateur | 24 Margaret Rose Crescent EH10 7EZ Edinburgh | United Kingdom | British | 190746580001 | |||||
| LAMEY, John Keith | Administrateur | 31 Franklands Drive KT15 1EG Addlestone Surrey | England | British | 13431090001 | |||||
| LONG, William Peter | Administrateur | Vine Cottage Ashwell SG7 5NW Royston Hertfordshire | British | 92829450001 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| MAC DAID, Denis James Anthony | Administrateur | The Waterside Church Lane Wappenbury CV33 9DW Royalleamington Spa Warwickshire | England | British | 77208310003 | |||||
| MACKENZIE, Andrew | Administrateur | Badgers Holt Foxcombe Drive Boars Hill OX1 5DL Oxford | British | 1728940001 | ||||||
| MCGARAHAN, Anthony Patrick | Administrateur | Laurel Bank Birch Avenue RH17 7SL Haywards Heath West Sussex | British | 77140730002 | ||||||
| MURRIN, Jonathan Charles | Administrateur | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | 115863170001 | ||||||
| PEACOCK, Raymond Anthony | Administrateur | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | 75750250002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRYANT HOMES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Wimpey Developments Limited | 06 avr. 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0