VERTEX ADMINISTRATION LIMITED

VERTEX ADMINISTRATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVERTEX ADMINISTRATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02138853
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VERTEX ADMINISTRATION LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe VERTEX ADMINISTRATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VERTEX ADMINISTRATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MARLBOROUGH STIRLING ADMINISTRATION LIMITED15 sept. 198715 sept. 1987
    JUMBOHASTY LIMITED08 juin 198708 juin 1987

    Quels sont les derniers comptes de VERTEX ADMINISTRATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour VERTEX ADMINISTRATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    17 pagesLIQ14

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 29 févr. 2016

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 5300 Daresbury Park, Cinnibar Court Daresbury Warrington WA4 4GE United Kingdom à 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR le 05 févr. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Kenneth Alan Tointon en tant qu'administrateur le 15 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Steven James Barker en tant que secrétaire le 21 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Chris Thompson en tant que directeur le 21 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    14 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Jessop House Jessop Avenue Cheltenham Gloucestershire GL50 3SH à 5300 Daresbury Park, Cinnibar Court Daresbury Warrington WA4 4GE le 14 juil. 2015

    1 pagesAD01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 5300 Daresbury Park, Cinnibar Court Daresbury Warrington WA4 4GE

    1 pagesAD04

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Steven James Barker le 12 juin 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gavin Keith James le 09 juin 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 avr. 2015

    État du capital au 23 avr. 2015

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Nomination de Mr Steven James Barker en tant que secrétaire le 20 août 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Stephen Bailey en tant que secrétaire le 20 août 2014

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    20 pagesAA

    Nomination de Stephen Bailey en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Stephen Gledhill en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 mars 2014

    État du capital au 24 mars 2014

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de VERTEX ADMINISTRATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    Jessop House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    Jessop House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector44173560008
    TOINTON, Kenneth Alan
    Daresbury Park, Cinnibar Court
    Daresbury
    WA4 4GE Warrington
    5300
    United Kingdom
    Administrateur
    Daresbury Park, Cinnibar Court
    Daresbury
    WA4 4GE Warrington
    5300
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant104528310001
    BAILEY, Stephen
    Cavendish Road
    Heaton Mersey
    SK4 3DN Stockport
    32
    England And Wales
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cavendish Road
    Heaton Mersey
    SK4 3DN Stockport
    32
    England And Wales
    United Kingdom
    188590210001
    BARKER, Steven James
    Daresbury Park, Cinnibar Court
    Daresbury
    WA4 4GE Warrington
    5300
    United Kingdom
    Secrétaire
    Daresbury Park, Cinnibar Court
    Daresbury
    WA4 4GE Warrington
    5300
    United Kingdom
    190322740001
    BIRKETT, Timothy Lloyd
    17 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    17 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant99698140001
    COLLINS, Richard Hawke
    Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    5
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    5
    Gloucestershire
    United Kingdom
    152998570001
    FRITCHIE, Andrew Peel
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    British79149580001
    GLEDHILL, Stephen
    Knighton Drive
    Four Oaks
    B74 4QP Sutton Coldfield
    18
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    Knighton Drive
    Four Oaks
    B74 4QP Sutton Coldfield
    18
    West Midlands
    United Kingdom
    174673920001
    HAYFIELD, Colin John
    1 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    1 Mossway
    HP9 1TG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60766060001
    KIRBY, Jonathan Francis
    61 North Street
    Winchcombe
    GL54 5PS Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    61 North Street
    Winchcombe
    GL54 5PS Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSolicitor32916230002
    PRENTICE, Ruby
    21 Podsmead Road
    GL1 5PB Gloucester
    Gloucestershire
    Secrétaire
    21 Podsmead Road
    GL1 5PB Gloucester
    Gloucestershire
    British11842360001
    SHEFFIELD, Anne Louise
    Flat 15 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7EY London
    Secrétaire
    Flat 15 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7EY London
    British85634660002
    THOMAS, Stephen Jeremy
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishSolicitor97303290001
    UU SECRETARIAT LIMITED
    Haweswater House, Lingley Mere Business Park
    Lingley Green Avenue Great Sankey
    WA5 3LP Warrington
    Secrétaire
    Haweswater House, Lingley Mere Business Park
    Lingley Green Avenue Great Sankey
    WA5 3LP Warrington
    94063410003
    ADAMS, Andrea
    9 Beech Drive
    Whalley
    BB7 9RA Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    9 Beech Drive
    Whalley
    BB7 9RA Clitheroe
    Lancashire
    EnglandBritishH R Director124716290001
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Administrateur
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritishAccounant62452090001
    CHARLESWORTH, Edward Mark
    11 Lambridge Place
    Larkhall
    BA1 6RU Bath
    Somerset
    Administrateur
    11 Lambridge Place
    Larkhall
    BA1 6RU Bath
    Somerset
    BritishDirector77811240002
    CHILD, David Michael
    Woodleigh
    Staplow
    H28 1MP Ledbury
    Herefordshire
    Administrateur
    Woodleigh
    Staplow
    H28 1MP Ledbury
    Herefordshire
    United KingdomBritishManaging Director112452210001
    CHITTENDEN, Jeffrey George John
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    United Kingdom
    Administrateur
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Manager123115670003
    CHITTENDEN, Jeffrey George John
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    Administrateur
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    United KingdomBritishOperations Manager123115670003
    COLEMAN, David
    West View Cottage
    Worthing Road
    RH13 9BH Southwater
    West Sussex
    Administrateur
    West View Cottage
    Worthing Road
    RH13 9BH Southwater
    West Sussex
    BritishFinancial Services123508560001
    COLVIN, Andrew James
    12 Ifield Close
    RH1 6SW Redhill
    Surrey
    Administrateur
    12 Ifield Close
    RH1 6SW Redhill
    Surrey
    BritishManaging Director112969670001
    COXELL, Graham
    Greka
    Noverton Avenue, Prestbury
    GL52 5DB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Greka
    Noverton Avenue, Prestbury
    GL52 5DB Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishManaging Director73332850002
    COYLE, Robert Charles
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    Jessop House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Jessop Avenue
    GL50 3SH Cheltenham
    Jessop House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector160497630001
    DRURY, Thomas Waterworth
    Legh Cottage
    Legh Road
    WA16 8LS Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Legh Cottage
    Legh Road
    WA16 8LS Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish/CanadianCompany Director29701240002
    EVANS, Huw Dewi
    Brecon House
    Charlton Hill
    GL53 9NE Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Brecon House
    Charlton Hill
    GL53 9NE Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director8307600004
    FORSTER, Stephan Dewi
    3 Chambon Close
    SN16 9QE Minety
    Wiltshire
    Administrateur
    3 Chambon Close
    SN16 9QE Minety
    Wiltshire
    BritishDirector121261220001
    FRITCHIE, Andrew Peel
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector79149580001
    GALES, David Robert
    4 The Pavillions End
    GU15 2LD Camberley
    Surrey
    Administrateur
    4 The Pavillions End
    GU15 2LD Camberley
    Surrey
    BritishCompany Director22498240002
    GITTINS, John Anthony
    East Wing Leighton House
    Leighton Road Neston
    CH64 3SW Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    East Wing Leighton House
    Leighton Road Neston
    CH64 3SW Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritishCompany Director164311370001
    GRAHAM, Richard Halton
    307 Sunup Holiday Park
    Ellicottville
    1473196 New York
    New York 14731-9604
    Usa
    Administrateur
    307 Sunup Holiday Park
    Ellicottville
    1473196 New York
    New York 14731-9604
    Usa
    CanadianManaging Director120665310001
    GREENSLADE, Stuart Leslie
    Fox Warren Tower Road
    GU26 6SL Hindhead
    Surrey
    Administrateur
    Fox Warren Tower Road
    GU26 6SL Hindhead
    Surrey
    BritishCompany Director22498250001
    HARKNESS, John
    Gretton Hill Farm
    Winchcombe
    GL54 5EW Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Gretton Hill Farm
    Winchcombe
    GL54 5EW Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant64624190001
    HUNT, Andrew James
    Millswood
    Old Neighbouring, Chalford
    GL6 8AA Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Millswood
    Old Neighbouring, Chalford
    GL6 8AA Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector54503850003
    LYONS, Ian Robert
    7 Fairleigh Rise
    Kington Langley
    SN15 5QF Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    7 Fairleigh Rise
    Kington Langley
    SN15 5QF Chippenham
    Wiltshire
    BritishCompany Director73718750001

    VERTEX ADMINISTRATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Confirmatory english law security document
    Créé le 08 juin 2012
    Livré le 15 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guggenheim Corporate Funding, Llc as Agent and Trustee for the Lenders
    Transactions
    • 15 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    English law security document
    Créé le 31 oct. 2011
    Livré le 08 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guggenheim Corporate Funding, Llc as Agent and Trustee for the Lenders
    Transactions
    • 08 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    An english law security document
    Créé le 27 avr. 2011
    Livré le 11 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge over all real property, fixed charge on book debts, bank accounts, investments, uncalled capital, and goodwill and floating charge over the undertaking and all assets present and future. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guggenheim Corporate Funding, Llc
    Transactions
    • 11 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating security document
    Créé le 17 mai 2007
    Livré le 29 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America Securities Limited as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 29 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge
    Créé le 02 mars 2002
    Livré le 22 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    5,000,100 ordinary shares of £1.00 each in the capital of sun life of canada (UK) group services limited (being the entire issued capital of sun life of canada (UK) group services limited as at the date of creation of the fixed charge) and any other shares in the capital of sun life of canada (UK) group services limited which may thereafter be registered in the name of or beneficially owned by the company.
    Personnes ayant droit
    • Sun Life Assurance Company of Canada (U.K.) Limited
    Transactions
    • 22 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 déc. 1999
    Livré le 07 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 15 avr. 1988
    Livré le 22 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 26 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    VERTEX ADMINISTRATION LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 févr. 2016Commencement of winding up
    10 août 2017Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kirstie Jane Provan
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor 31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    Begbies Traynor 31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0