RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02144551 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ?
Adresse du siège social | Critchleys Llp Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street OX1 2EP Oxford |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 30 Gresham Street London EC2V 7QN England à Critchleys Llp Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP le 10 janv. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Maclaurin Elliott en tant que directeur le 29 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Rensburg Sheppards Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 mai 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 Gresham Street London England EC2V 7QP à 30 Gresham Street London EC2V 7QN le 25 mai 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Maclaurin Elliott le 23 mai 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Peter Wragg le 23 mai 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Divers Section 519 | 3 pages | MISC | ||||||||||
Divers Section 519 | 2 pages | MISC | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILDAY, Steven Robert | Secrétaire | Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street OX1 2EP Oxford Critchleys Llp | 179668020001 | |||||||
HOOLEY, Iain William | Administrateur | Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street OX1 2EP Oxford Critchleys Llp | England | British | Secretary | 153896520001 | ||||
WRAGG, Jonathan Peter | Administrateur | Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street OX1 2EP Oxford Critchleys Llp | England | British | Director | 66863530002 | ||||
CONG, Kathy | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7QP London 2 England England | 154646310001 | |||||||
HOOLEY, Iain William | Secrétaire | Quayside House Canal Wharf LS11 5PU Leeds West Yorkshire | 152835310001 | |||||||
WATTS, Paula Mary | Secrétaire | Canal Wharf LS11 5PU Leeds Quayside House West Yorkshire United Kingdom | British | Chartered Sec | 120535120002 | |||||
BATTYE WIMPENNY & DAWSON LIMITED | Secrétaire | Quayside House Canal Wharf LS11 5PU Leeds | 9767320002 | |||||||
ADDENBROOKE, Christopher | Administrateur | 72 Huddersfield Road Meltham, Holmfirth HD9 4AG Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 88420110001 | |||||
AITON, Alexander William | Administrateur | 27 Mannering Road G41 3SW Glasgow Lanarkshire | British | Company Director | 72128500001 | |||||
ALLEN, Robert Anthony | Administrateur | Redwell Farm Fouldshaw Lane Dacre HG3 4AP Harrogate | England | British | Accountant | 10212990003 | ||||
ANYSZ, Barry Aubrey | Administrateur | 10 Wigton Chase Wigton Lane LS17 8SG Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 18679440001 | ||||
BAKEWELL, Ian William | Administrateur | Rolleston Oldfield Drive L60 6SS Heswall Wirral Merseyside | British | Stockbroker | 28051590002 | |||||
BARBER, Graham Keith | Administrateur | Westview Wood Lane Bardsey LS17 9AW Leeds West Yorkshire | British | Financial Planner | 56204700002 | |||||
BARLOW, George Bradwall | Administrateur | Bradwall Manor CW11 1RF Sandbach Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 880900003 | ||||
BATES, Nigel Gordon | Administrateur | 236 Mansfield Road DE1 3RB Derby Derbyshire | British | Stockbroker | 41965010001 | |||||
BROADBENT, Christopher John Bates | Administrateur | Ladyroyd Busker Lane Scissett HD8 9JU Huddersfield Yorkshire | British | Company Director | 5575600001 | |||||
BROWN, Samuel James | Administrateur | Fairhaven 40 Hanwood Heights Dundonald BT16 0XU Belfast Co Down | British | Stockbroker | 45945080001 | |||||
BURNS, Michael Hamer | Administrateur | The Rookery Hall Lane Lathom L40 5UG Ormskirk Lancashire | England | British | Company Director | 43863650001 | ||||
BURTON, Peter | Administrateur | 4 Lodge Farm Mews North Anston S25 4FW Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 114216630001 | ||||
CARR, Douglas | Administrateur | Wonderful Cottage Priestcliffe Taddington SK17 9TN Buxton Derbyshire | British | Stockbroker | 36570700001 | |||||
CARTER, Jennifer Lea | Administrateur | 24 The Orchards Pickmere WA16 0LB Knutsford Cheshire | British | Stockbroker | 71415410001 | |||||
CONNER, Anthony Paul | Administrateur | 3 Manor Farm Mews Beighton S20 1GG Sheffield South Yorkshire | British | Chartered Accountant | 63952550001 | |||||
CONNOR, John Nigel | Administrateur | 64 Leeds Road HG2 8BQ Harrogate North Yorkshire | British | Company Director | 72128540001 | |||||
COOKE, Martin James Paul | Administrateur | Lion House Tattenhall Road CH3 9QH Tattenhall Chester | England | British | Stockbroker | 9767370002 | ||||
COOKSON, Stuart Peter Hatton | Administrateur | The Garden Flat Clavis 96 Meols Drive, West Kirby CH48 5DB Wirral Merseyside | British | Stockbroker | 76616720001 | |||||
CORRY, William Brian Noel | Administrateur | Rossili 56 Knocklofty Park BT4 3ND Belfast County Antrim Northern Ireland | British | Company Director | 28185010001 | |||||
CRAVEN, John Henry | Administrateur | 2 Manor House Mews Kildwick Grange Kildwick BD20 9AD Keighley West Yorkshire | British | Company Director | 1668550001 | |||||
CUMMING, Alastair | Administrateur | Dippin Lodge Mains Of Buchlyvie Buchlyvie FK8 3NR Stirling | British | Stockbroker | 45756020001 | |||||
CURRIE, Ian William | Administrateur | Crabtree House Hillhouse Lane PR6 8NR Brindle Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 72590450001 | ||||
DERBYSHIRE, George Michael | Administrateur | 2 Welbeck Close Dronfield Woodhouse S18 8ZT Dronfield Derbyshire | British | Stockbroker | 66967450001 | |||||
DICKINSON, Michael John | Administrateur | Chiddingfold Cottage Northfield Lane Highburton HD8 0QT Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 8083230001 | |||||
DUNN, David Jonathan | Administrateur | 77 Riverdale Road S10 3FE Sheffield South Yorkshire | British | Stockbroker | 43280180001 | |||||
DYSON, John Geoffrey Thomas | Administrateur | Green Bank Thurgoland S35 7AE Sheffield South Yorkshire | British | Company Director | 28051640001 | |||||
ELLIOTT, Stephen Maclaurin | Administrateur | EC2V 7QN London 30 Gresham Street England | United Kingdom | South African | Banker | 78535360001 | ||||
EYRE, Thomas Frank Alexander | Administrateur | The Granary Laurel Farm Court Walton Head Lane, Kirkby Overblow HG3 1HG Harrogate North Yorkshire | British | Company Director | 66243570002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rensburg Sheppards Plc | 06 avr. 2016 | EC2V 7QN London 30 Gresham Street England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Créé le 21 déc. 2001 Livré le 05 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions £9,919.00. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Terms of business agreement | Créé le 21 sept. 1999 Livré le 23 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the agreement and under any transaction | |
Brèves mentions With full title guarantee by way of first fixed charge and pledge over all deposits and margin and all securities, documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 03 avr. 1990 Livré le 04 avr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All shares, stock & other securities of any description which one for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
RENSBURG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilit é ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0