EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED

EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02146363
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Robert Charles Gale en tant que directeur le 29 nov. 2013

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    97 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Caroline Bernadette Elizabeth Withers le 14 mars 2013

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Joanne Christine Tillbrook en tant que directeur le 31 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Caroline Bernadette Elizabeth Withers en tant qu'administrateur le 31 déc. 2012

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 nov. 2012

    État du capital au 16 nov. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Joanne Christine Tillbrook en tant qu'administrateur le 16 sept. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Joanne Christine Tillbrook en tant que directeur le 16 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Joanne Christine Tillbrook en tant qu'administrateur le 16 sept. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Joanne Christine Tillbrook en tant que directeur le 16 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Joanne Christine Tillbrook en tant qu'administrateur le 16 sept. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Mario Mackenzie en tant que directeur le 16 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 160 Great Portland Street London W1W 5QA le 04 avr. 2011

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Virgin Media Secretaries Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Virgin Media Directors Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151024970001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Secrétaire
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secrétaire
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Administrateur
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Administrateur
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DELAHUNTY, Joseph John
    6 Thornhill Way
    TW17 0AW Shepperton
    Middlesex
    Administrateur
    6 Thornhill Way
    TW17 0AW Shepperton
    Middlesex
    British2077360001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GALTEAU, Philippe Xavier
    10 Rue De La Cure
    75016 Paris
    France
    Administrateur
    10 Rue De La Cure
    75016 Paris
    France
    French34577670001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Administrateur
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    JOHNSON, Edward Neil
    Tolcarne
    Stonebridge Fields Shalford
    GU4 8EE Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Tolcarne
    Stonebridge Fields Shalford
    GU4 8EE Guildford
    Surrey
    British37444720001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    Administrateur
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritish152304230002
    NEARY, Christopher John
    4 Effingham Place
    KT24 5JT Effingham
    Surrey
    Administrateur
    4 Effingham Place
    KT24 5JT Effingham
    Surrey
    British47022960003
    SCHAEFFER, Thomas Rebadow
    Mill Run Mill Lane
    White Lilies Island
    SL4 5JH Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Mill Run Mill Lane
    White Lilies Island
    SL4 5JH Windsor
    Berkshire
    Usa27263600001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Administrateur
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Administrateur
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1997
    Livré le 20 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fleming Leasing (Number 4) Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1997
    Livré le 20 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Commercial Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1997
    Livré le 20 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Natwest Specialist Finance Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1997
    Livré le 20 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Natwest Specialist Finance Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1997
    Livré le 15 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the beneficiaries) on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all undertaking property and assets present and future including goodwill intellectual property benefit of licences all earnings all debts shares and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0