ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02147548
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    14a Anyards Road
    KT11 2JZ Cobham
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GREAT NORTHERN WAREHOUSE LIMITED09 sept. 199609 sept. 1996
    TROWBRIDGE SHOPPING CENTRE LIMITED08 oct. 199308 oct. 1993
    MERLIN INTERNATIONAL PROPERTIES (TROWBRIDGE) LIMITED11 avr. 198811 avr. 1988
    LAWNSHIRE LIMITED15 juil. 198715 juil. 1987

    Quels sont les derniers comptes de ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de David Anthony Venus en tant que secrétaire le 05 mars 2012

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 nov. 2011

    État du capital au 03 nov. 2011

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Lutidine House Newark Lane Ripley Surrey GU23 6BS le 26 févr. 2010

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2009

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées du secrétaire David Anthony Venus le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes établis au 30 avr. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2006

    5 pagesAA

    Comptes établis au 30 avr. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes complets modifiés jusqu'au 30 avr. 2004

    10 pagesAAMD

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2004

    11 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JEVANS, Helen
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritishManagement/Secretary29320580001
    JEVANS, Peter Theodore
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor35560390001
    JEVANS, Helen
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    BritishCompany Director29320580001
    VENUS, David Anthony
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    British38563740001
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    British38563740001
    HAINSWORTH, Keith
    Cotman House
    Shennington
    OX15 6NH Banbury
    Oxon
    Administrateur
    Cotman House
    Shennington
    OX15 6NH Banbury
    Oxon
    BritishDirector10878320001
    HINDS, Charles William Victor
    10 Chelford Drive
    Swinton
    M27 9HJ Salford
    Administrateur
    10 Chelford Drive
    Swinton
    M27 9HJ Salford
    United KingdomBritishCouncil Leader35404370001
    HUTCHINS, Colin George
    29 Arundel Avenue
    East Ewell
    KT17 2RF Epsom
    Surrey
    Administrateur
    29 Arundel Avenue
    East Ewell
    KT17 2RF Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant5973350001
    JURY, Graham Richard
    6 Strachan Place
    SW19 4RH London
    Administrateur
    6 Strachan Place
    SW19 4RH London
    BritishDirector5973370001
    LINBOURN, John
    Westwood Lenacre Street
    Eastwell
    TN26 1JD Ashford
    Kent
    Administrateur
    Westwood Lenacre Street
    Eastwell
    TN26 1JD Ashford
    Kent
    BritishDirector25281880002

    ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 05 juin 1991
    Livré le 20 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any associated company or any guarantor to the chargee on any account whatsoever. Under the terms of a debenture of even date
    Brèves mentions
    Assigns & charges by way of first fixed charge the benefit of the contracts or appointments described in schedule as detailed on form 395 (see form 395 for full detail(s).
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 20 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juin 1991
    Livré le 20 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any associated company or any guarantor to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    (See form 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 20 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 14 juil. 1993Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 12 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 25 févr. 1998Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
      • Numéro de dossier 1
    Mortgage debenture
    Créé le 23 mai 1991
    Livré le 07 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a castle place shopping centre, market street, trowbridge, wiltshire title no wt 76007. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Isle of Man Limited
    Transactions
    • 07 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1990
    Acquis le 05 juin 1991
    Livré le 07 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from bury retail park limited to the bank on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    L/H land k/a 47 upper grosvenor street, and 47 reeves mews, westminster, london, title no: ln 250863.
    Personnes ayant droit
    • Isle of Man Bank Limited
    Transactions
    • 07 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 mai 1990
    Livré le 18 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any associated company or guarantor (as defined) to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    A legal mortgage over f/h property k/a castle place shopping centre trowbridge, wiltshire title no wt 76007 a fixed & equitable charge over all and any proceeds of sale of the property all present & future goodwill floating charge over the undertaking and all property and assets present and future (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 18 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 20 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or merlin international properties limited or any associated company or any guarantor (as defined on the debenture to united dominions trust limited on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust LTD
    Transactions
    • 20 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ABBEYGATE MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 juin 1991Instrument date
    Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan D Kenningham
    51 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8PP
    practitioner
    51 Grays Inn Road
    London
    WC1X 8PP
    John Charles Heath
    4/8 Tabernacle Street
    London
    EC2A 4LU
    practitioner
    4/8 Tabernacle Street
    London
    EC2A 4LU

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0