THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED

THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHOROGOOD ASSOCIATES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02149616
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED ?

    • Activités de conseil en technologies de l'information (62020) / Information et communication

    Où se situe THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ealing Cross
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JETBUDGET LIMITED23 juil. 198723 juil. 1987

    Quels sont les derniers comptes de THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2023

    42 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2022

    40 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 août 2022Clarification HMRC CONFIRATION DUTY PAID

    Annulation d'actions. État du capital au 24 juin 2022

    • Capital: GBP 40,333.00
    4 pagesSH06

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2021

    38 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2020

    34 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de International House 7 High Street 2nd Floor Nw London W5 5DB à Ealing Cross 85 Uxbridge Road London W5 5BW le 22 oct. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2019

    36 pagesAA

    Cessation de la nomination de Pauline Julia Honigsberger en tant que directeur le 01 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Ita Rosemary Harris en tant qu'administrateur le 01 sept. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Siobhan Elisabeth Boyer en tant qu'administrateur le 01 sept. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Balacky en tant que directeur le 30 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2018

    33 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2017

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2016

    33 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2015

    27 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2016

    État du capital au 03 juin 2016

    • Capital: GBP 40,363
    SH01

    Qui sont les dirigeants de THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOYER, Siobhan
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    Secrétaire
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    159391160001
    BOYER, Siobhan Elisabeth
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    Administrateur
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    EnglandBritishChartered Accountant84558950004
    HARRIS, Ita Rosemary
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    Administrateur
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    Northern IrelandBritishHr Manager273946940001
    JONES, Trevor Robert
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    Administrateur
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    EnglandBritishManaging Director11404220002
    NICOL, Peter William
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    Administrateur
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    EnglandBritishInvestment Analyst113238420001
    ENGASSER, Jeremy
    Flat 9 The Warwick 68 Richmond Hill
    TW10 6RH Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    Flat 9 The Warwick 68 Richmond Hill
    TW10 6RH Richmond
    Surrey
    BritishComputer Systems Analyst67784270003
    HARRIS, Ita
    Rosowen
    5 Roxburgh Place
    BT34 3EW Rostrevor
    County Down
    Secrétaire
    Rosowen
    5 Roxburgh Place
    BT34 3EW Rostrevor
    County Down
    British69299590002
    STRACHAN, Jo-Anne
    3 Fulmer Place
    Fulmer
    SL3 6HR Slough
    Berkshire
    Secrétaire
    3 Fulmer Place
    Fulmer
    SL3 6HR Slough
    Berkshire
    Australian11404230001
    BALACKY, Paul
    7 High Street
    2nd Floor Nw
    W5 5DB London
    International House
    England
    Administrateur
    7 High Street
    2nd Floor Nw
    W5 5DB London
    International House
    England
    United KingdomBritishDirector Principal Consultant53614660002
    DERBYSHIRE, Steven
    36 Cambridge Road
    TW1 2HL East Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    36 Cambridge Road
    TW1 2HL East Twickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director53462650001
    EDWARDS, John William
    Pinkneys Cottage
    47 Golden Ball Lane Pinkneys Green
    SL6 6NW Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Pinkneys Cottage
    47 Golden Ball Lane Pinkneys Green
    SL6 6NW Maidenhead
    Berkshire
    BritishComputer Consultant20289310003
    ENGASSER, Jeremy
    Flat 9 The Warwick 68 Richmond Hill
    TW10 6RH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    Flat 9 The Warwick 68 Richmond Hill
    TW10 6RH Richmond
    Surrey
    BritishComputer Systems Analyst67784270003
    HONIGSBERGER, Pauline Julia
    7 High Street
    2nd Floor Nw
    W5 5DB London
    International House
    England
    Administrateur
    7 High Street
    2nd Floor Nw
    W5 5DB London
    International House
    England
    EnglandBritishDirector Principal Consultant32063580007
    KIGHTLEY, Michael John
    7 High Street
    2nd Floor Nw
    W5 5DB London
    International House
    England
    Administrateur
    7 High Street
    2nd Floor Nw
    W5 5DB London
    International House
    England
    United KingdomBritishDirector75918010001
    STRACHAN, Jo-Anne
    3 Fulmer Place
    Fulmer
    SL3 6HR Slough
    Berkshire
    Administrateur
    3 Fulmer Place
    Fulmer
    SL3 6HR Slough
    Berkshire
    AustralianComputer Systems Analyst11404230001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Trevor Robert Jones
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    06 avr. 2016
    85 Uxbridge Road
    W5 5BW London
    Ealing Cross
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    THOROGOOD ASSOCIATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 nov. 2009
    Livré le 13 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 13 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 03 août 1998
    Livré le 06 août 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1987
    Livré le 05 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Office unit b, dralda house crendon street, high wycombe bucks.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 nov. 1987
    Livré le 25 nov. 1987
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0