NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED

NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02154270
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED ?

    • Commerce de détail de pièces et accessoires pour véhicules automobiles (45320) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Etel House
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2020
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2021
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juil. 2020
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation12 août 2020
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juil. 2019
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    6 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    État du capital après une attribution d'actions au 26 mars 2019

    • Capital: GBP 1,003
    4 pagesSH01

    Nomination de Mr Takeshi Fukuda en tant qu'administrateur le 01 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Notification de Takeshi Fukuda en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2019

    2 pagesPSC01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 27 mars 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 26/03/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    5 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 01 avr. 2018

    • Capital: GBP 1,002.00
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Cessation de la nomination de Kenji Murai en tant que directeur le 01 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de Kenji Murai en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 févr. 2018

    1 pagesPSC07

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Lynott le 08 mars 2018

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Mr Mark Lynott en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mars 2018

    2 pagesPSC04

    Nomination de Mr Wataru Goroku en tant qu'administrateur le 02 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Notification de Wataru Goroku en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 févr. 2018

    2 pagesPSC01

    Nomination de Mr Mark Lynott en tant qu'administrateur le 01 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIS, Ian Vincent
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    British159267490001
    FUKUDA, Takeshi
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    EnglandJapanese247034300001
    GOROKU, Wataru
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    EnglandJapanese243265590001
    LYNOTT, Mark
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    EnglandBritish186944700001
    DARCY, Netta Chrystal
    Greenacres Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2RN Saltburn By The Sea
    Cleveland
    Secrétaire
    Greenacres Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2RN Saltburn By The Sea
    Cleveland
    British3904370001
    SHARP, Michael David
    Grange House
    Long Lane, Hornby
    DL6 2JG Northallerton
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Grange House
    Long Lane, Hornby
    DL6 2JG Northallerton
    North Yorkshire
    British164313640001
    SHARP, Michael David
    Grange House
    Long Lane, Hornby
    DL6 2JG Northallerton
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Grange House
    Long Lane, Hornby
    DL6 2JG Northallerton
    North Yorkshire
    British164313640001
    ALLEN, Peter John
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    Administrateur
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    United KingdomBritish182524310001
    DARCY, Anthony Frederick
    Brotton Cote Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2PJ Saltburn By The Sea
    Cleveland
    Administrateur
    Brotton Cote Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2PJ Saltburn By The Sea
    Cleveland
    United KingdomBritish3904380001
    DARCY, Benjamin Paul Pat
    13 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    13 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish120528390001
    DARCY, Frederick
    Greenacres Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2RN Saltburn By The Sea
    Cleveland
    Administrateur
    Greenacres Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2RN Saltburn By The Sea
    Cleveland
    British3904390001
    DARCY, Ian William
    Church Farm
    Westerdale
    YO21 2DT Whitby
    North Yorkshire
    Administrateur
    Church Farm
    Westerdale
    YO21 2DT Whitby
    North Yorkshire
    EnglandBritish3904400001
    DARCY, Netta Chrystal
    Greenacres Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2RN Saltburn By The Sea
    Cleveland
    Administrateur
    Greenacres Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2RN Saltburn By The Sea
    Cleveland
    United KingdomBritish3904370001
    DARCY, Raymond John
    Windrush Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2PJ Saltburn By The Sea
    Cleveland
    Administrateur
    Windrush Saltburn Road
    Brotton
    TS12 2PJ Saltburn By The Sea
    Cleveland
    United KingdomBritish3904410001
    GRIGGS, Roger
    39 Penley's Grove Street
    YO31 7PW York
    North Yorkshire
    Administrateur
    39 Penley's Grove Street
    YO31 7PW York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish127602660001
    HALAI, Ravilal
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    Administrateur
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    United KingdomBritish159265300001
    HARDIMAN, John Patrick
    52 Denton Avenue
    LS8 1LE Leeds
    Administrateur
    52 Denton Avenue
    LS8 1LE Leeds
    British41590890001
    KIMBARA, Yutaka
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    Administrateur
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    EnglandJapanese159263630001
    MARSHALL, Gavin John
    Longlands
    TS4 2JY Middlesbrough
    Warelands Way
    Cleveland
    England
    Administrateur
    Longlands
    TS4 2JY Middlesbrough
    Warelands Way
    Cleveland
    England
    United KingdomScottish51507690003
    MARSHALL, Gavin John
    27 Jesmond Park West
    High Heaton
    NE7 7BU Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    27 Jesmond Park West
    High Heaton
    NE7 7BU Newcastle Upon Tyne
    United KingdomScottish51507690003
    MURAI, Kenji
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    Administrateur
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    EnglandJapanese95702340002
    OGURA, Kazushi
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth Garden City
    Etel House
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth Garden City
    Etel House
    Hertfordshire
    England
    EnglandJapanese150485750001
    PARKER, Stephen Charles
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    Administrateur
    Fourth Avenue
    SG6 2TT Letchworth
    Stapleton's (Tyre Services) Limited
    Herts
    United Kingdom
    United KingdomBritish41868120003
    SHARP, Michael David
    Grange House
    Long Lane, Hornby
    DL6 2JG Northallerton
    North Yorkshire
    Administrateur
    Grange House
    Long Lane, Hornby
    DL6 2JG Northallerton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish164313640001
    SLADE, Mark Richard
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    EnglandBritish185568260001
    SIGNIFICANT VISION LIMITED - 248 5650
    Brayton Lane
    Brayton
    YO8 9DU Selby
    Sycamore Lodge
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Brayton Lane
    Brayton
    YO8 9DU Selby
    Sycamore Lodge
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement248 5650
    125312000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Takeshi Fukuda
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    01 avr. 2019
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Non
    Nationalité: Japanese
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Wataru Goroku
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    02 févr. 2018
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Non
    Nationalité: Japanese
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Mark Lynott
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    01 févr. 2018
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Yutaka Kimbara
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    06 avr. 2016
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Oui
    Nationalité: Japanese
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Kenji Murai
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    06 avr. 2016
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Oui
    Nationalité: Japanese
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Mark Richard Slade
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    06 avr. 2016
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth
    Etel House
    Hertfordshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Melbourne Holdings (Northern) Limited
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth Garden City
    Etel House
    Hertfordshire
    England
    06 avr. 2016
    Avenue One
    SG6 2HU Letchworth Garden City
    Etel House
    Hertfordshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement1811326
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    NORTH EASTERN TYRE & EXHAUSTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 10 sept. 2009
    Livré le 18 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the south side of middle engine lane, north shields t/no TY277275 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 10 sept. 2009
    Livré le 18 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at longlands road middlesbrough t/no CE170120 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 10 sept. 2009
    Livré le 18 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    147 gelderd road leeds t/no WYK108118 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 2007
    Livré le 19 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at st james business park knaresborough north yorkshire t/n NYK255406,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 déc. 1999
    Livré le 24 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over credit balance.
    Créé le 27 oct. 1992
    Livré le 03 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over deposit account re: barclays bank PLC re: norh eastern tyre & exhausts limited business premium account no 20141054,together with all interest accrued theron. Please see doc for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1991
    Livré le 15 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit h, warelands way, middlesborough, cleveland t/no.CE110658.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0