NTL CAMBRIDGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNTL CAMBRIDGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02154841
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NTL CAMBRIDGE LIMITED ?

    • Autres activités de télécommunications (61900) / Information et communication

    Où se situe NTL CAMBRIDGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NTL CAMBRIDGE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAMBRIDGE CABLE LIMITED20 mai 198820 mai 1988
    JULY LIMITED14 août 198714 août 1987

    Quels sont les derniers comptes de NTL CAMBRIDGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour NTL CAMBRIDGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Nomination de Roderick Gregor Mcneil en tant qu'administrateur le 09 mars 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Thomas Castell en tant que directeur le 09 mars 2020

    1 pagesTM01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Nomination de Mr William Thomas Castell en tant qu'administrateur le 09 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Dominic Dunn en tant que directeur le 09 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP à 1 More London Place London SE1 2AF le 31 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 juil. 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410015 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410014 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410017 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410013 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410022 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410016 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410023 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410018 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 021548410019 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de NTL CAMBRIDGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Gillian Elizabeth
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Secrétaire
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    151342510001
    HIFZI, Mine Ozkan
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish182167230001
    MCNEIL, Roderick Gregor
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish267964620001
    ASHBURNER, Ronald Leslie George
    5 The Avenue
    UB10 8NR Uxbridge
    Middlesex
    Secrétaire
    5 The Avenue
    UB10 8NR Uxbridge
    Middlesex
    British102503610001
    CHEW, Mun Chun
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Secrétaire
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Singaporean36124880001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Secrétaire
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Secrétaire
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Secrétaire
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    MARSHALL, Brian
    Owls Hall Chimney Street
    Hundon
    CO10 8DX Sudbury
    Suffolk
    Secrétaire désigné
    Owls Hall Chimney Street
    Hundon
    CO10 8DX Sudbury
    Suffolk
    British900008320001
    PROCTOR, Martina
    37a
    Madingley Road
    CB3 0EL Cambridge
    Secrétaire
    37a
    Madingley Road
    CB3 0EL Cambridge
    British43777590001
    TVETER, Eric John
    12 The Mallards
    CB5 8HJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    12 The Mallards
    CB5 8HJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Usa53395160001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secrétaire
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    ALDEN, Peter James
    9 Redwood Lodge
    Grange Road
    CB3 9AU Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    9 Redwood Lodge
    Grange Road
    CB3 9AU Cambridge
    Cambridgeshire
    British40967330001
    BRODSKY, Julian Alvin
    1004 Swallow Drive
    Cherryhill
    New Jersey
    08003
    Usa
    Administrateur
    1004 Swallow Drive
    Cherryhill
    New Jersey
    08003
    Usa
    American11120770001
    CAMPBELL, Gerald Daniel
    18 Ringwood Avenue
    N2 9NS London
    Administrateur
    18 Ringwood Avenue
    N2 9NS London
    American48066760001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Administrateur
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CASTELL, William Thomas
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish248424970001
    CHEW, Mun Chun
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Administrateur
    15 Rectory Farm Road
    Little Wilbraham
    CB1 5LB Cambridge
    Singaporean36124880001
    CHIA, Choon Wei, Doctor
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Administrateur
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Singaporean35806810001
    CHURCHILL, Daniel Creighton
    Helliers Chapel Road
    Buckleberry Common
    RG7 6NN Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Helliers Chapel Road
    Buckleberry Common
    RG7 6NN Reading
    Berkshire
    American34603880001
    CHURCHILL, Daniel Creighton
    Helliers Chapel Road
    Buckleberry Common
    RG7 6NN Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Helliers Chapel Road
    Buckleberry Common
    RG7 6NN Reading
    Berkshire
    American34603880001
    CLASEN, Robert Burke
    2021 Avenda Chico
    CA 92660 Newport Beach
    California
    Usa
    Administrateur
    2021 Avenda Chico
    CA 92660 Newport Beach
    California
    Usa
    American34348730001
    CLASEN, Robert Burke
    2021 Avenda Chico
    CA 92660 Newport Beach
    California
    Usa
    Administrateur
    2021 Avenda Chico
    CA 92660 Newport Beach
    California
    Usa
    American34348730001
    COSGROVE, Charles Henry
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    Administrateur
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    American36156420001
    CURRY, Christopher John
    5 River Lane
    Brampton
    PE18 8PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    5 River Lane
    Brampton
    PE18 8PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British64368820001
    DAVENPORT, Hugo Riddell Agard Bramhall
    19 Wingate Way
    CB2 2HD Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    19 Wingate Way
    CB2 2HD Cambridge
    Cambridgeshire
    British6298250001
    DAVIES, Richard James
    The Library Suite The Mansion
    KT16 0QB Ottershaw Park
    Surrey
    Administrateur
    The Library Suite The Mansion
    KT16 0QB Ottershaw Park
    Surrey
    American45182540001
    DUNN, Robert Dominic
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish179134020002
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Administrateur
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GOWEN, Wayne Lyle
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    British39694410001
    GOWEN, Wayne Lyle
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    New House Fairoak Lane
    Oxshott
    KT22 0TP Leatherhead
    Surrey
    British39694410001
    GRAFIN VON BROCKDORFF AHLFELDT, Claire Louise Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish166267770001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Administrateur
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    HO, Lam Phoh
    129 Tanah Kerah Kechill Road
    1646 Singapore
    Administrateur
    129 Tanah Kerah Kechill Road
    1646 Singapore
    Singaporean36156430001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NTL CAMBRIDGE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    29 juin 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2591237
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NTL CAMBRIDGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 juil. 2019
    Livré le 10 juil. 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 10 juil. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 mai 2019
    Livré le 24 mai 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 24 mai 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 mars 2017
    Livré le 23 mars 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 23 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 févr. 2017
    Livré le 07 févr. 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 07 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 avr. 2016
    Livré le 27 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 27 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 avr. 2015
    Livré le 06 mai 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 06 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 mars 2015
    Livré le 01 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 01 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 janv. 2015
    Livré le 06 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 06 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 avr. 2014
    Livré le 10 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 10 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 mars 2014
    Livré le 02 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 02 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 juin 2013
    Livré le 14 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transactions
    • 14 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Confirmation deed
    Créé le 03 mars 2011
    Livré le 15 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the security trustee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor acknowledges and agrees to the issuance of the new notes, the new guarantees and the new indenture and the transactions contemplated thereby and hereby confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of liens under and subject to the terms of the liens, the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 15 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 08 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 08 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Confirmation deed
    Créé le 15 avr. 2010
    Livré le 29 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 29 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 22 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 22 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Créé le 16 juin 2006
    Livré le 29 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 29 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 03 mars 2006
    Livré le 10 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 10 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 24 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juin 2004
    Livré le 30 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 30 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 nov. 1998
    Livré le 11 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the east side of ainsworth street. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 06 janv. 1998
    Livré le 23 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due, owing or incurred to the chargee in its capacity as security trustee by the company and/or all or any of the other companies named therein under or pursuant to the agreement and/or the composite guarantee and debenture and/or the security trust deed and/or any of the other security documents, all obligations and liabilities due owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein to the interest rate beneficiaries (or any of them) in respect of the interest rate protection arrangements, and to the bond providers, if any (or any of them) in respect of any indemnity from the company and/or all or any of the other companies named therein issued in connection with the bond provision arrangements
    Brèves mentions
    Westbrook centre first floor block d milton road cambridge CB4 1YG; unit 208 science park milton road cambridge CB4 4GZ; unit 304 science park milton road cambridge CB4 4GZ, for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York
    Transactions
    • 23 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First fixed charge deed
    Créé le 07 nov. 1994
    Livré le 17 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan facility letter of even date and this deed
    Brèves mentions
    All hardware which is subject of a supply agreement dated 28 january 1994 and entered into between the company and nokia telecommunications limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Intenational Nederlanden Bank Nv
    Transactions
    • 17 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 sept. 1990
    Livré le 09 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at 72A ainsworth street, cambridge, title no. CB27930.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NTL CAMBRIDGE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juil. 2019Commencement of winding up
    12 mai 2020Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0