COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED

COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02163525
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    • fabrication d'autres machines à usage spécial n.c.a. (28990) / Industries manufacturières

    Où se situe COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    J.A. COATES ENGINEERING COMPANY LIMITED11 sept. 198711 sept. 1987

    Quels sont les derniers comptes de COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    24 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Avis de l'ordonnance de révocation de l'administrateur de ses fonctions

    19 pagesAM16

    Avis de nomination d'un administrateur remplaçant ou supplémentaire

    3 pagesAM11

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 mars 2017

    38 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    72 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    16 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    72 pages2.17B

    Satisfaction de la charge 021635250023 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Spring Place Millfold Whitworth Lancashire OL12 8DN à 3 Hardman Street Spinningfields Manchester M3 3AT le 28 sept. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 021635250023

    1 pagesMR05

    Inscription de la charge 021635250023, créée le 27 juin 2016

    40 pagesMR01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mars 2016

    État du capital au 07 mars 2016

    • Capital: GBP 57,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    23 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul George Ruocco en tant que directeur le 17 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 20 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUNTER, Alison
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    Secrétaire
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    163374980001
    BRANTON, Kenneth William
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    Administrateur
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    EnglandBritish117991720001
    EVE, Timothy Clive
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    Administrateur
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    Isle Of ManBritish97404580014
    COATES, Christine
    11 Park Crescent
    New Line
    OL13 9RL Bacup
    Lancashire
    Secrétaire
    11 Park Crescent
    New Line
    OL13 9RL Bacup
    Lancashire
    British37308920001
    EVE, Timothy Clive
    Spring Place
    Millfold
    OL12 8DN Whitworth
    Lancashire
    Secrétaire
    Spring Place
    Millfold
    OL12 8DN Whitworth
    Lancashire
    British97404580001
    BARROWMAN, Douglas Alan
    High Whins
    Macclesfield Road
    SK9 7BL Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    High Whins
    Macclesfield Road
    SK9 7BL Alderley Edge
    Cheshire
    British66728580003
    COAD, Peter Herbert
    22 Woodhey Grove
    Syke
    Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    22 Woodhey Grove
    Syke
    Rochdale
    Lancashire
    British33646850001
    COATES, Christine
    11 Park Crescent
    New Line
    OL13 9RL Bacup
    Lancashire
    Administrateur
    11 Park Crescent
    New Line
    OL13 9RL Bacup
    Lancashire
    British37308920001
    COATES, Jack Anthony
    11 Park Crescent
    New Line
    OL13 9RL Bacup
    Lancashire
    Administrateur
    11 Park Crescent
    New Line
    OL13 9RL Bacup
    Lancashire
    EnglandBritish33646860001
    RUOCCO, Paul George
    Spring Place
    Millfold
    OL12 8DN Whitworth
    Lancashire
    Administrateur
    Spring Place
    Millfold
    OL12 8DN Whitworth
    Lancashire
    EnglandBritish61638480004

    COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2016
    Livré le 04 juil. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Knox Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 sept. 2016Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 14 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 2009
    Livré le 06 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £320,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and assets, book debts, machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ecf Asset Finance PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 30 sept. 2009
    Livré le 09 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £320,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Food processing and confectionery equipment (bch (coates) 500KG rotachill stainless steel cooling system seriel no:2/16850 (2006) with E200 control. Bch (coates) 200K capacity stainless steel tilting revolver coating pan seriel no:2/16849. Four liquorice twist extrusion line please see image for further charges.
    Personnes ayant droit
    • Ecf Asset Finance PLC
    Transactions
    • 09 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattel mortgage
    Créé le 27 déc. 2007
    Livré le 09 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chattels (as specified in schedule 2 of the chattel mortgage) documents relating to the chattels the benefit of all contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Paul George Ruocco, Douglas Alan Barrowman and Timothy Clive Eve
    Transactions
    • 09 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 déc. 2007
    Livré le 09 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Paul George Ruocco, Douglas Alan Barrowman and Timothy Clive Eve
    Transactions
    • 09 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of life policy
    Créé le 27 déc. 2007
    Livré le 04 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no 011550361-7 with legal and general assurance society on the life of brendan joseph kennedy all money that may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of life policy
    Créé le 27 déc. 2007
    Livré le 04 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no L0198704272 with scottish equitable PLC on the life of steven longstaff all money that may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Assignment of life policy
    Créé le 27 déc. 2007
    Livré le 04 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no L0193114272 with scottish equitable PLC on the life of peter john jamieson all money that may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Assignment of life policy
    Créé le 27 déc. 2007
    Livré le 04 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy no L0190514272 with scottish equitable PLC on the life of matthew cottam all money that may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 déc. 2007
    Livré le 04 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 16 janv. 2007
    Livré le 20 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Scottish equitable, policy number L0190514272DG, dated 11 november 2005 for the sum of £150000, life assured matthew cottam together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 16 janv. 2007
    Livré le 20 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Scottish equitable, policy number L0198704272DP, dated 11/11/2005 for the sum of £150000, life assured steven longstaff together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 16 janv. 2007
    Livré le 20 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Scottish equitable, policy number L0193114272, dated 12/11/2004, for the sum of £150000, life assured peter jamieson together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 21 juil. 2006
    Livré le 24 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £276,000.00 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Bch (coates) 500KG capacity rotachill stainless steel cooling system ser no 2/16850, bch (coates) 200KG capacity stainless steel tilting revolver ser no 2/16849 and four colour liquorice twist extrusion line for details of further equipment charged please refer to form 395.
    Personnes ayant droit
    • European Corporate Finance PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Chattel mortgage
    Créé le 07 juil. 2005
    Livré le 20 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Beyler type C4100X10E guillotine s/n 7511261, capacity 4100MM x 10MM, with power back gauge. Higgs double ended polisher. Ace minor band surface grinder. For further details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2005
    Livré le 13 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Legal charge
    Créé le 07 juil. 2005
    Livré le 13 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H interest in land and buildings on the north side of millford facit whitworth f/h t/n LA523956. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Legal charge
    Créé le 07 juil. 2005
    Livré le 13 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H interest in land lying to the west of market street facit part of f/h t/n LA762884. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Legal charge
    Créé le 07 juil. 2005
    Livré le 13 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H interest in spring mill and adjoining land and buildings spring place market street facit f/h t/n LA627219. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Legal charge
    Créé le 07 juil. 2005
    Livré le 13 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H interest in land at whitworth excluding any buildings erected on it being part of the property registered f/h t/n LA647825. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 janv. 2009
    Legal charge
    Créé le 23 mars 1995
    Livré le 31 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the west of market street, whitworth, lancashire t/no. LA723049 part.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 oct. 1992
    Livré le 27 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    COATES ENGINEERING (INTERNATIONAL) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 sept. 2016Administration started
    29 mai 2019Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Edward Terence Kerr
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Ian James Gould
    Bdo Llp 3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    practitioner
    Bdo Llp 3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    practitioner
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0