BARCLAYS INDUSTRIAL LEASING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BARCLAYS INDUSTRIAL LEASING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02172547 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BARCLAYS INDUSTRIAL LEASING LIMITED ?
| Adresse du siège social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BARCLAYS INDUSTRIAL LEASING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour BARCLAYS INDUSTRIAL LEASING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 4 pages | 4.71 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 Churchill Place London E14 5HP | 2 pages | AD02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP le 07 sept. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Geoffrey Ridout en tant que directeur le 23 mars 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Jeremy Marchant en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 24 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Thomas Geoffrey Ridout en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Marchant en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 25 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Darren Hare en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Mcmillan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Darren Mark Hare en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 25 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 2 pages | AD03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 2 pages | AD02 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | 403a | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | 403a | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BARCLAYS INDUSTRIAL LEASING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCOSEC LIMITED | Secrétaire | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 69140360004 | |||||
| ROWBERRY, Duncan John | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 49237880004 | |||||
| RUFFELL, Lara Catherine | Secrétaire | 23 Meadowlands Chineham RG24 8XL Basingstoke Hampshire | British | 69140140002 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Secrétaire | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| ABLITT, Denis Raymond | Administrateur | Woodcocks 38 Park Avenue, Old Basing RG24 7HT Basingstoke Hampshire | British | 71782000001 | ||||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Administrateur | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Administrateur | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Administrateur | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| DOWDING, Eric Robert | Administrateur | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Administrateur | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| HARE, Darren Mark | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 147858890001 | |||||
| HASSELL, Brian Charles | Administrateur | 10 Blenheim Close CM21 0BE Sawbridgeworth Hertfordshire | Great Britain | British | 45384250002 | |||||
| HILLS, Richard Allan | Administrateur | 11 Countess Gardens Littledown BH7 7RR Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | 71778800001 | |||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Administrateur | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MARCHANT, Jeremy | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 154144600001 | |||||
| MCMILLAN, Richard John | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 68601920003 | ||||||
| RIDOUT, Thomas Geoffrey | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 155056490001 | |||||
| ROWAN, Charles Paul | Administrateur | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| SILCOCK, Frank Avis | Administrateur | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| WEAL, Barry | Administrateur | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Administrateur | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| BAROMETERS LIMITED | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 57357300002 |
BARCLAYS INDUSTRIAL LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of mortgage | Créé le 08 juin 2004 Livré le 15 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its present and future right and interest in the vessel being the 317,000 dwt referred to as hull no. 1415 and named M.T. "C.vision" under construction by samsung heavy industries co., LTD.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security assignment | Créé le 28 mars 2003 Livré le 10 avr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The assigned property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Sublessee security agreement | Créé le 30 déc. 1992 Livré le 14 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing the performance of certain covenants due or to become due form the company to the chargee under the terms of the sublease dated 24/11/92 and from the company under the terms of the head lease dated 24/11/92 | |
Brèves mentions All of the grantor's right title and interest as lessee in the head lease and as secured party in the head security agreement (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Secondary lease security assignment | Créé le 30 déc. 1992 Livré le 13 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due form i/s scansvane and/or thomas berg to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30/12/92 | |
Brèves mentions All the lessees right title and interest in and to the assigned payments and all sums paid or payable in respect thereof (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
BARCLAYS INDUSTRIAL LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0