L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED

L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéL & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02174321
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Thomas Andrew Dale en tant que directeur le 29 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Thomas Andrew Dale en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anton Clive Jeary en tant que directeur le 04 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Inchcape Transition Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2018

    5 pagesPSC05

    Modification des coordonnées du secrétaire Inchcape Uk Corporate Management Limited le 01 avr. 2018

    3 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT à First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN le 09 avr. 2018

    2 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Inchcape Transition Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2016

    État du capital au 23 juin 2016

    • Capital: GBP 500,100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin Peter Wheatley le 29 janv. 2016

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin Peter Wheatley le 29 janv. 2016

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2015

    État du capital au 25 juin 2015

    • Capital: GBP 500,100
    SH01

    Cessation de la nomination de Ross Mccluskey en tant que directeur le 14 mai 2015

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    Secrétaire
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5200589
    100307260071
    WHEATLEY, Martin Peter
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritish55180460002
    FOULKES, Julian
    Honeysuckle Cottage Buckhurst Lane
    TN5 6JY Wadhurst
    East Sussex
    Secrétaire
    Honeysuckle Cottage Buckhurst Lane
    TN5 6JY Wadhurst
    East Sussex
    British74191700001
    HIGNETT, Samuel Timothy
    The Warren
    Rock Robin Hill
    TN5 6RY Wadhurst
    East Sussex
    Secrétaire
    The Warren
    Rock Robin Hill
    TN5 6RY Wadhurst
    East Sussex
    British12331730002
    NIX, Christopher Bernard
    52 Riddlesdown Road
    CR8 1JJ Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    52 Riddlesdown Road
    CR8 1JJ Croydon
    Surrey
    British32399540001
    TOWNSEND, Peter
    1 Walks House
    The Pantiles
    TN2 5TN Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    1 Walks House
    The Pantiles
    TN2 5TN Tunbridge Wells
    Kent
    British92881110001
    WHEATLEY, Martin Peter
    Amberley Lambridge Wood Road
    RG9 3BS Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Amberley Lambridge Wood Road
    RG9 3BS Henley On Thames
    Oxfordshire
    British55180460001
    CROMPTON, Simon Peel
    18 Claremont Road
    TN1 1SZ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    18 Claremont Road
    TN1 1SZ Tunbridge Wells
    Kent
    British62040970002
    DALE, Thomas Andrew
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United KingdomBritish260286850001
    FOULKES, Julian
    Honeysuckle Cottage Buckhurst Lane
    TN5 6JY Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    Honeysuckle Cottage Buckhurst Lane
    TN5 6JY Wadhurst
    East Sussex
    British74191700001
    HIGNETT, Sally Irene
    The Warren
    Rock Robin Hill
    TN5 6RY Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    The Warren
    Rock Robin Hill
    TN5 6RY Wadhurst
    East Sussex
    British12331750002
    HIGNETT, Samuel Timothy
    The Warren
    Rock Robin Hill
    TN5 6RY Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    The Warren
    Rock Robin Hill
    TN5 6RY Wadhurst
    East Sussex
    United KingdomBritish12331730002
    JEARY, Anton Clive
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    EnglandBritish169892630001
    MCCLUSKEY, Ross
    Langford Lane
    Kidlington
    OX5 1HT Oxford
    Inchcape House
    Administrateur
    Langford Lane
    Kidlington
    OX5 1HT Oxford
    Inchcape House
    United KingdomBritish165677350002
    MCCORMACK, Connor
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    Administrateur
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish108832810002
    NIX, Christopher Bernard
    52 Riddlesdown Road
    CR8 1JJ Croydon
    Surrey
    Administrateur
    52 Riddlesdown Road
    CR8 1JJ Croydon
    Surrey
    British32399540001
    ORCHARD, Sharn Hyatt
    Orchard House
    Outwood Lane
    RH1 4LR Bletchingley
    Surrey
    Administrateur
    Orchard House
    Outwood Lane
    RH1 4LR Bletchingley
    Surrey
    British73976740001
    POTTS, Graeme John
    Bramley House
    Burchetts Green Road
    SL6 6RR Littlewick Green
    Berkshire
    Administrateur
    Bramley House
    Burchetts Green Road
    SL6 6RR Littlewick Green
    Berkshire
    EnglandBritish89665780001
    RABAN, Mark Douglas
    18 Orchard Lane
    MK43 7BP Harrold
    Bedfordshire
    Administrateur
    18 Orchard Lane
    MK43 7BP Harrold
    Bedfordshire
    United KingdomBritish261262130001
    RONCHETTI, Marc Arthur
    New Road
    Croxley Green
    WD3 3EP Rickmansworth
    22
    Hertfordshire
    Administrateur
    New Road
    Croxley Green
    WD3 3EP Rickmansworth
    22
    Hertfordshire
    EnglandBritish123180830001
    TOWNSEND, Peter
    1 Walks House
    The Pantiles
    TN2 5TN Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    1 Walks House
    The Pantiles
    TN2 5TN Tunbridge Wells
    Kent
    British92881110001
    WALLWORK, Paul Anthony Hewitt
    Baytree Cottage
    Church Road Lyndon
    LE15 8TU Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Baytree Cottage
    Church Road Lyndon
    LE15 8TU Oakham
    Rutland
    British113014520001
    WRITER, David Christopher Russell
    2 Stone Cottages
    Hawkhurst Road
    TN19 7RA Hurst Green
    East Sussex
    Administrateur
    2 Stone Cottages
    Hawkhurst Road
    TN19 7RA Hurst Green
    East Sussex
    British12331760001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Inchcape Transition Limited
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    First Floor Unit 3140 Park Square
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom (England) Companies House
    Numéro d'enregistrement4053624
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 déc. 2000
    Livré le 08 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 30 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: sgl 478793.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 30 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: sgl 478794.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 30 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: sgl 450363.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 30 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: SGL353830.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 30 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: sgl 493864.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 janv. 1988
    Livré le 20 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All those monies which may from time to time be owing to the company by bmw (GB) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 janv. 1988
    Livré le 20 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All those monies which may from time to time be owing to the company by bmw (GB) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Personnes ayant droit
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transactions
    • 20 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 déc. 1987
    Livré le 07 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1987
    Livré le 08 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 1 & 2 blue riband estate factory lane croydon l/b of croydon T.N. sgl 220142.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 19 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0