L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02174321 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?
| Adresse du siège social | First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Andrew Dale en tant que directeur le 29 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Andrew Dale en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anton Clive Jeary en tant que directeur le 04 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Inchcape Transition Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2018 | 5 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Inchcape Uk Corporate Management Limited le 01 avr. 2018 | 3 pages | CH04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT à First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN le 09 avr. 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Inchcape Transition Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin Peter Wheatley le 29 janv. 2016 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin Peter Wheatley le 29 janv. 2016 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Ross Mccluskey en tant que directeur le 14 mai 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | Secrétaire | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square United Kingdom |
| 100307260071 | ||||||||||
| WHEATLEY, Martin Peter | Administrateur | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | England | British | 55180460002 | |||||||||
| FOULKES, Julian | Secrétaire | Honeysuckle Cottage Buckhurst Lane TN5 6JY Wadhurst East Sussex | British | 74191700001 | ||||||||||
| HIGNETT, Samuel Timothy | Secrétaire | The Warren Rock Robin Hill TN5 6RY Wadhurst East Sussex | British | 12331730002 | ||||||||||
| NIX, Christopher Bernard | Secrétaire | 52 Riddlesdown Road CR8 1JJ Croydon Surrey | British | 32399540001 | ||||||||||
| TOWNSEND, Peter | Secrétaire | 1 Walks House The Pantiles TN2 5TN Tunbridge Wells Kent | British | 92881110001 | ||||||||||
| WHEATLEY, Martin Peter | Secrétaire | Amberley Lambridge Wood Road RG9 3BS Henley On Thames Oxfordshire | British | 55180460001 | ||||||||||
| CROMPTON, Simon Peel | Administrateur | 18 Claremont Road TN1 1SZ Tunbridge Wells Kent | British | 62040970002 | ||||||||||
| DALE, Thomas Andrew | Administrateur | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | United Kingdom | British | 260286850001 | |||||||||
| FOULKES, Julian | Administrateur | Honeysuckle Cottage Buckhurst Lane TN5 6JY Wadhurst East Sussex | British | 74191700001 | ||||||||||
| HIGNETT, Sally Irene | Administrateur | The Warren Rock Robin Hill TN5 6RY Wadhurst East Sussex | British | 12331750002 | ||||||||||
| HIGNETT, Samuel Timothy | Administrateur | The Warren Rock Robin Hill TN5 6RY Wadhurst East Sussex | United Kingdom | British | 12331730002 | |||||||||
| JEARY, Anton Clive | Administrateur | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | England | British | 169892630001 | |||||||||
| MCCLUSKEY, Ross | Administrateur | Langford Lane Kidlington OX5 1HT Oxford Inchcape House | United Kingdom | British | 165677350002 | |||||||||
| MCCORMACK, Connor | Administrateur | New College House Alchester Road OX26 1UN Chesterton Oxfordshire | United Kingdom | British | 108832810002 | |||||||||
| NIX, Christopher Bernard | Administrateur | 52 Riddlesdown Road CR8 1JJ Croydon Surrey | British | 32399540001 | ||||||||||
| ORCHARD, Sharn Hyatt | Administrateur | Orchard House Outwood Lane RH1 4LR Bletchingley Surrey | British | 73976740001 | ||||||||||
| POTTS, Graeme John | Administrateur | Bramley House Burchetts Green Road SL6 6RR Littlewick Green Berkshire | England | British | 89665780001 | |||||||||
| RABAN, Mark Douglas | Administrateur | 18 Orchard Lane MK43 7BP Harrold Bedfordshire | United Kingdom | British | 261262130001 | |||||||||
| RONCHETTI, Marc Arthur | Administrateur | New Road Croxley Green WD3 3EP Rickmansworth 22 Hertfordshire | England | British | 123180830001 | |||||||||
| TOWNSEND, Peter | Administrateur | 1 Walks House The Pantiles TN2 5TN Tunbridge Wells Kent | British | 92881110001 | ||||||||||
| WALLWORK, Paul Anthony Hewitt | Administrateur | Baytree Cottage Church Road Lyndon LE15 8TU Oakham Rutland | British | 113014520001 | ||||||||||
| WRITER, David Christopher Russell | Administrateur | 2 Stone Cottages Hawkhurst Road TN19 7RA Hurst Green East Sussex | British | 12331760001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inchcape Transition Limited | 06 avr. 2016 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
L & C AUTO SERVICES (CROYDON) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Créé le 31 janv. 2003 Livré le 18 févr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 29 déc. 2000 Livré le 08 janv. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 juin 1994 Livré le 30 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: sgl 478793. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 juin 1994 Livré le 30 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: sgl 478794. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 juin 1994 Livré le 30 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: sgl 450363. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 juin 1994 Livré le 30 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: SGL353830. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 juin 1994 Livré le 30 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Part of greenoaks, brighton road, south croydon, l/b of croydon t/no: sgl 493864. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 15 janv. 1988 Livré le 20 janv. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All those monies which may from time to time be owing to the company by bmw (GB) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 15 janv. 1988 Livré le 20 janv. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All those monies which may from time to time be owing to the company by bmw (GB) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 déc. 1987 Livré le 07 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 30 nov. 1987 Livré le 08 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Units 1 & 2 blue riband estate factory lane croydon l/b of croydon T.N. sgl 220142. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0