MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02175295 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 oct. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 oct. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 17 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 16 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 28 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 31 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Latham Nelson le 25 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 29 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de James Stefan Haluch en tant que directeur le 26 févr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 29 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin John Jarvey le 16 janv. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Lee Milner en tant que directeur le 12 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 29 pages | AA | ||
Modification des détails de Enterprise Holding Company No1 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Sherard Secretariat Services Limited le 02 sept. 2019 | 1 pages | CH04 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ à Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB le 02 sept. 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Mr Kevin John Jarvey en tant qu'administrateur le 12 déc. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr James Stefan Haluch en tant qu'administrateur le 12 déc. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| JARVEY, Kevin John | Administrateur | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 185176610001 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Administrateur | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 36191090004 | |||||||||
| BIRCH, Paul | Secrétaire | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | British | 76116640002 | ||||||||||
| BURNS, Martin David | Secrétaire | Westlands Mountview Road Claygate KT10 0UB Esher Surrey | British | 147570820001 | ||||||||||
| COTTRIDGE, John Melvyn | Secrétaire | 78 Tankerville Drive SS9 3DF Leigh On Sea Essex | British | 40562810001 | ||||||||||
| PATEL, Shamir | Secrétaire | 109 Gleneagle Road Streatham SW16 6AZ London | British | 49444440001 | ||||||||||
| SEEAR, Robert William | Secrétaire | 4 North Lane Haynes MK45 3PW Bedfordshire | British | 36546180002 | ||||||||||
| SHOESMITH, James | Secrétaire | 1 Park Leys NN11 4AS Daventry Northamptonshire | British | 120551800001 | ||||||||||
| ADLARD, Clifford Roy | Administrateur | 53 Hunters Gate TF13 6BW Much Wenlock Shropshire | British | 49444830003 | ||||||||||
| ARNOLD, David Llewelyn | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 181213200001 | |||||||||
| BRADLEY, Michael Paul | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Gordon House Lancashire United Kingdom | England | British | 100477780001 | |||||||||
| BURNS, Martin David | Administrateur | Westlands Mountview Road Claygate KT10 0UB Esher Surrey | England | British | 147570820001 | |||||||||
| CHASTON, Stuart Paul | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 126271790001 | |||||||||
| DANIEL, Graham | Administrateur | Cote Des Vardes Montville Road St Peter Port GY1 1BQ Guernsey Channel Islands | British | 49444700001 | ||||||||||
| DAY, Stephen John | Administrateur | Becca House Becca Lane Aberford LS25 3BD Leeds | England | British | 59028300002 | |||||||||
| EDMONDSON, Robert | Administrateur | Speke Road Garston L19 2PH Liverpool The Matchworks England | England | British | 203736680001 | |||||||||
| EWELL, Melvyn | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 61515760002 | |||||||||
| FRASER, Ian Ellis | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||||||
| GAVAN, John Vincent | Administrateur | 23 Fulshaw Avenue SK9 5JE Wilmslow Cheshire | England | British | 36153790001 | |||||||||
| HALUCH, James Stefan | Administrateur | 20 Colmore Curcus Queensway B4 6AT Birmingham Colmore Plaza England England | England | British | 280543490001 | |||||||||
| JOYCE, Martin John | Administrateur | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | England | British | 72254420003 | |||||||||
| KIRKBY, Neil Robert Ernest | Administrateur | 5 Dashwood Close Grappenhall WA4 3JA Warrington Cheshire | England | British | 51438040006 | |||||||||
| LAVERY, Kevin Gregory | Administrateur | Old Colony House 6, South King Street M2 6DQ Manchester | United Kingdom | British | 115961810003 | |||||||||
| MCGILL, David Jonathan | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Gordon House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 106246460001 | |||||||||
| MCGRORY, Jack | Administrateur | 12 Woodlands Park Scarcroft LS14 3JU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 96596920001 | |||||||||
| MCLAUGHLIN, Owen Gerard | Administrateur | Lancaster House Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancashire | United Kingdom | British | 17129800004 | |||||||||
| MILNER, Andrew Lee | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 133714170002 | |||||||||
| PARKER, Gary | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Gordon House Lancashire United Kingdom | England | British | 50372730001 | |||||||||
| PATEL, Shamir | Administrateur | 109 Gleneagle Road Streatham SW16 6AZ London | British | 49444440001 | ||||||||||
| ROSS, Ian Peter | Administrateur | 58 Westminster Gardens Marsham Street SW1P 4JG London | British | 36333100002 | ||||||||||
| SEEAR, Robert William | Administrateur | 4 North Lane Haynes MK45 3PW Bedfordshire | British | 36546180002 | ||||||||||
| SEEAR, Robert | Administrateur | 21 Farm Street W1X 7RD London | British | 36546180001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Holding Company No1 Limited | 06 avr. 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0