LLPPS (GEMS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLLPPS (GEMS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02176610
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LLPPS (GEMS) LIMITED ?

    • Éducation primaire (85200) / Enseignement

    Où se situe LLPPS (GEMS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LLPPS (GEMS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LADY LANE PARK PREPARATORY SCHOOL LIMITED12 oct. 198712 oct. 1987

    Quels sont les derniers comptes de LLPPS (GEMS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LLPPS (GEMS) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LLPPS (GEMS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2014

    État du capital au 28 oct. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dino Sunny Varkey le 19 mars 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Global Education Management Systems Limited le 19 mars 2013

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire M&R Secretarial Services Limited le 19 févr. 2013

    2 pagesCH04

    Certificat de changement de nom

    Company name changed lady lane park preparatory school LIMITED\certificate issued on 02/07/13
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Changement d'adresse du siège social de 112 Hills Road Cambridge CB2 1PH le 18 mars 2013

    1 pagesAD01

    Comptes établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mars 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mars 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Global Education Management System Limited le 01 oct. 2010

    2 pagesCH02

    Comptes établis au 31 mars 2009

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dino Sunny Varkey le 19 nov. 2009

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Global Education Management System Limited le 23 oct. 2009

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire M&R Secretarial Services Limited le 23 oct. 2009

    1 pagesCH04

    legacy

    2 pages403a

    Qui sont les dirigeants de LLPPS (GEMS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    M&R SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    100 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Botanic House
    England
    Secrétaire
    100 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Botanic House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05065514
    99412960001
    VARKEY, Dino Sunny
    Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    100
    England
    Administrateur
    Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    100
    England
    United Arab EmiratesIndianDirector99007620001
    GLOBAL EDUCATION MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED
    Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    100
    England
    Administrateur
    Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    100
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04742550
    98789860012
    JOHNSON, David William
    22 Sunnyside Close
    Reedsholme
    BB4 8PE Rossendale
    Lancashire
    Secrétaire
    22 Sunnyside Close
    Reedsholme
    BB4 8PE Rossendale
    Lancashire
    BritishFinance Director2299140001
    MITCHELL, James Patrick
    54 Kent Road
    HG1 2EU Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    54 Kent Road
    HG1 2EU Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor46193460002
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Accountant51283590002
    THORNTON, Stuart Graham
    Thorncroft
    Morton Lane East Morton
    BD16 2EP Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Thorncroft
    Morton Lane East Morton
    BD16 2EP Keighley
    West Yorkshire
    British6130630001
    CUMMINS, Simon Paul Jeremiah
    9 Harland Way
    TN4 0TQ Tunbridge Wells
    Administrateur
    9 Harland Way
    TN4 0TQ Tunbridge Wells
    BritishSchools Director98960160001
    FITZMAURICE, Andrew
    96 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8RA Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    96 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8RA Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishChief Executive70922490001
    JOHNSON, David William
    Jolly Hall Farm
    Oakenhead Wood Old Road
    BB4 8TX Rossendale
    Lancashire
    Administrateur
    Jolly Hall Farm
    Oakenhead Wood Old Road
    BB4 8TX Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director2299140002
    MCNEANY, Kevin Joseph
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director2299150001
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director51283590002
    THORNTON, Kathleen Lesley
    Thorncroft Morton Lane
    East Morton
    BD20 5AP Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Thorncroft Morton Lane
    East Morton
    BD20 5AP Keighley
    West Yorkshire
    BritishSchool Headmistress63862960001
    THORNTON, Stuart Graham
    Thorncroft
    Morton Lane East Morton
    BD16 2EP Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Thorncroft
    Morton Lane East Morton
    BD16 2EP Keighley
    West Yorkshire
    BritishManaging Director-Haulage/Transport Operator6130630001

    LLPPS (GEMS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 juin 2004
    Livré le 02 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 févr. 1997
    Livré le 19 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h land and premises being land to the east of lady lane bingley bradford west yorkshire and the present and future goodwill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 févr. 1997
    Livré le 19 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land to the east of lady lane bingley bradford west yorkshire t/n WYK479165 and the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 19 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 21 mai 1992
    Livré le 01 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the f/h land and premises k/a lady cottage, lady lane, bingley, bradford title no. Wyk 499798 together with l/h land and buildings at lady lane, bingley bradford title no. WYK436839 and WYK450098 together with l/h playing fields at ladypark avenue, bingley, bradford title no. WYK506126 and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks, P.L.C.
    Transactions
    • 01 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 mai 1992
    Livré le 28 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 11 juil. 1989
    Livré le 27 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Shop unit 1, the green lady lane, bingley, west yorkshire assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 juil. 1989Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 11 juil. 1989
    Livré le 27 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lane park preparatory school, the green, lady lane, bingley, west yorkshireassigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 28 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 janv. 1989
    Livré le 06 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lady lane park preparatory school, lady lane, bingley west yorkshire, title no wyk 385462 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 28 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0