LONDON FIELDS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLONDON FIELDS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02180400
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LONDON FIELDS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe LONDON FIELDS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 Harley Street
    London
    W1G 9BR
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LONDON FIELDS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SELECTEARLY LIMITED19 oct. 198719 oct. 1987

    Quels sont les derniers comptes de LONDON FIELDS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour LONDON FIELDS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 janv. 2013

    État du capital au 02 janv. 2013

    • Capital: GBP 5,000,002
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 27 déc. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    11 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Robin Turner le 28 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Robin Turner le 27 juin 2011

    2 pagesCH01

    Divers

    Section 519 of companies act 2006
    1 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    10 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Collins en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Jennifer Grace Draper en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Robin Turner le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Robin Turner le 18 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Colin O'driscoll le 18 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David John Collins le 03 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Lane Tuckey le 03 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de LONDON FIELDS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Secrétaire
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    DRAPER, Jennifer Grace
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomAustralian152638020001
    O'DRISCOLL, Patrick Colin
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    United Kingdom
    EnglandIrish75571770001
    TUCKEY, James Lane
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019240001
    TURNER, Malcolm Robin
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Millbank Tower 21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th
    United Kingdom
    United KingdomBritish60293070008
    COOK, Kenneth Alan
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    Secrétaire
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    British100000003
    HARRISON, Linda Christine
    87 Kimberley Road
    CR0 2PZ Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    87 Kimberley Road
    CR0 2PZ Croydon
    Surrey
    British85883750001
    OSBORNE, Ian
    42 Brancaster Drive
    Mill Hill
    NW7 2SJ London
    Secrétaire
    42 Brancaster Drive
    Mill Hill
    NW7 2SJ London
    British44830690006
    BARROTT, Ronald Stephen
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    Administrateur
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish9892700002
    BERNERD, Elliott
    58 Old Church Street
    SW3 5DB London
    Administrateur
    58 Old Church Street
    SW3 5DB London
    British44790970001
    BROKE, Michael Haviland Adlington
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    Administrateur
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    British2996750001
    BUTLER, Robin Elliott
    Gatehouse Farm
    Rogate
    GU31 5DB Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Gatehouse Farm
    Rogate
    GU31 5DB Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritish2996760007
    CODLING, John Piers
    Smithy Cottage
    High Street
    HP7 0DY Little Missenden
    Bucks
    Administrateur
    Smithy Cottage
    High Street
    HP7 0DY Little Missenden
    Bucks
    British26235710001
    COLLINS, David John
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomAustralian119898430001
    HUGILL, William Nigel
    15 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    Administrateur
    15 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    EnglandBritish3015960006
    MCDIVEN, Ross Arnold
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Administrateur
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Australian108719480001
    MCGIVERN, Jayne Eleanor
    9 Northumberland Place
    W2 5BS London
    Administrateur
    9 Northumberland Place
    W2 5BS London
    British106563070002
    MINSHULL-BEECH, John Patrick
    33 Gerard Road
    SW13 9QH London
    Administrateur
    33 Gerard Road
    SW13 9QH London
    EnglandBritish85462230001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    Administrateur
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    EnglandFrench99292580003
    NATHAN, Timothy Paul
    19 Elms Avenue
    N10 2JN London
    Administrateur
    19 Elms Avenue
    N10 2JN London
    EnglandBritish104162560001
    PEDERSEN, Karen Maree
    22a Kentville Avenue
    Annandale
    Nsw 2038
    Administrateur
    22a Kentville Avenue
    Annandale
    Nsw 2038
    Australian109087760001
    PHILLIPS, David
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    Administrateur
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    United KingdomBritish65062400001
    SHAW, John Campbell
    Park House 2 John Woolf Court
    Northwick Park
    GL56 9RS Blackley
    Gloucestershire
    Administrateur
    Park House 2 John Woolf Court
    Northwick Park
    GL56 9RS Blackley
    Gloucestershire
    British104735000001

    LONDON FIELDS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Permanent finance security deed
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 04 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transactions
    • 04 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental guarantee and debenture (supplemental to a guarantee and debenture dated 31 october 1994)
    Créé le 23 déc. 1996
    Livré le 02 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    The f/h land and buildings k/a broadfield house cowley oxfordshire t/n ON88895 and land and buildings at plot 99 (k/a dunhams court) dunhams lane letchworth t/n HP239006 together with all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale thereof and the benefit of any covenants and insurances and a floating charge all the undertaking and assets whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 31 oct. 1994
    Livré le 08 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined in the charge) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings k/a broadfield house cowley oxfordshire t/no ON88895 and land & buildings at plot 99 (otherwise k/a dunhams court) dunhams lane letchworth t/no H0239006. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fourth supplemental guarantee and debenture
    Créé le 14 mai 1993
    Livré le 03 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and adviseclaim limited (or either of them) to the finance parties (or any of them) (as defined) on any account whatsoever under the terms of each of the finance documents to which the company and adviseclaim (or either of them) is a party
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subordination deed
    Créé le 07 mai 1992
    Livré le 26 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the senior finance documents or any other documents defined therein
    Brèves mentions
    Particulars as defined on form 395 see 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 07 mai 1992
    Livré le 26 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and adviseclaim limited to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for each of the finance parties (as defined in the credit agreement dated 10/3/92 under each of the finance documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    See from 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1992
    Livré le 26 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Adviseclaim Limited
    Transactions
    • 26 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0