GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02181315 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 8 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 déc. 2021 | 7 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR à C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham B3 3HN le 13 janv. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 déc. 2020 | 7 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 déc. 2019 | 8 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Barclays Group Archives Dallimore Road Wyhtenshawe Manchester M23 9JA | 2 pages | AD02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Andrew Richards en tant que directeur le 10 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , 1 Churchill Place, London, E14 5HP à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 17 janv. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 10 déc. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 26 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 26 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Mark Newbery en tant qu'administrateur le 30 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 28 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de David Mclean Currie en tant que directeur le 15 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCOSEC LIMITED | Secrétaire | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| BYLE, Philip Andrew Frank, Dr. | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 United Kingdom | England | British | 175463080001 | |||||
| HOUSTON, Andrew Brian | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 78025940002 | |||||
| NEWBERY, Mark | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 202085010001 | |||||
| BLATCHLY, Christopher Nigel | Secrétaire | Old Comptons Comptons Lane RH13 6DP Horsham West Sussex | British | 26871210002 | ||||||
| FITZROY, James Oliver Charles, Earl Of Euston | Secrétaire | 6 Vicarage Gardens W8 4AH London | British | 31319920001 | ||||||
| MARQUARD, Brian Andrew | Secrétaire | Thornhill Stockton Avenue GU13 8NS Fleet Hampshire | British | 69776400002 | ||||||
| MUNSON, Kim | Secrétaire | 115 Clapham Common Westside SW4 9BA London | British | 81133110001 | ||||||
| SLOCOMBE, Stephen Roy | Secrétaire | 92 Stratton Drive IG11 9HD Barking Essex | British | 55097590002 | ||||||
| SUTTON, Ian Nicholas | Secrétaire | 83a Hervey Road Blackheath SE3 8BX London | British | 37516040002 | ||||||
| ANSTEE, Eric Edward | Administrateur | Whitethorns Weydown Road GU27 1DS Haslemere Surrey | United Kingdom | British | 76479900001 | |||||
| ARCHIBALD, Michael | Administrateur | 47 North Street Oundle PE8 4AL Peterborough | British | 69280350003 | ||||||
| ASKARI, Hasan | Administrateur | 22 Ovington Square SW3 1LR London | United Kingdom | British | 41444890001 | |||||
| ASKARI, Hasan | Administrateur | 22 Ovington Square SW3 1LR London | United Kingdom | British | 41444890001 | |||||
| BALL, Christopher Charles | Administrateur | 147 Western Road SS9 2PB Leigh On Sea Essex | British | 5896130001 | ||||||
| BECK, Stanley Martin David | Administrateur | 50 Binscarth Road FOREIGN Toronto Ontario M4w 1g4 Canada | Canadian | 31509940001 | ||||||
| BERNAYS, Richard Oliver | Administrateur | 82 Elgin Crescent W11 2JL London | United Kingdom | British | 98729980001 | |||||
| BLATCHLY, Christopher Nigel | Administrateur | Old Comptons Comptons Lane RH13 6DP Horsham West Sussex | British | 26871210002 | ||||||
| BLATCHLY, Christopher Nigel | Administrateur | Old Comptons Comptons Lane RH13 6DP Horsham West Sussex | British | 26871210002 | ||||||
| BOLSOVER, Michael Timothy | Administrateur | Wakehurst Limes Close Bramshott GU30 7SL Liphook Hampshire | England | British | 104281460001 | |||||
| BOOTHMAN, Clive Nicholas | Administrateur | 28 Baskerville Road SW18 3RS London | British | 24493710001 | ||||||
| CARTER, Kevin James, Dr | Administrateur | Brantwood 23 Fairway Merrow GU1 2XL Guildford Surrey | British | 10570530006 | ||||||
| CARTER, Noland | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | American | 44738820002 | ||||||
| CLARK, Stephen | Administrateur | The Grey House Langton Road Langton Green TN3 0HP Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 52747390002 | |||||
| CURRIE, David Mclean | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | Scotland | British | 136790250001 | |||||
| DACOMBE, William John Armstrong | Administrateur | Mullion Cottage Well Lane SW14 7AJ London | British | 7810590001 | ||||||
| DAVIES, Mark Edward Trehearne | Administrateur | 26 Chester Street SW1X 7BL London | England | British | 82536300001 | |||||
| DEPEL, Cary Allen | Administrateur | 41 Winchendon Road SW6 5DH London | American | 62528900001 | ||||||
| DYCE, Alexander Hamilton | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 101888140002 | ||||||
| EMERY, Peter | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 205452510001 | |||||
| ERITH, Robert Felix | Administrateur | Shrubs Farm Lamarsh CO8 5EA Bures Essex | England | British | 8832330001 | |||||
| FRANKLIN, Robert Charles | Administrateur | 24 Mcglashan Court M5M 4M6 Toronto Ontario | Canadian | 33994160001 | ||||||
| GEORGESON, Hans Iain | Administrateur | Company Secretarial 7 Churchill Place E14 5HP London | British | 110099730001 | ||||||
| GORDON, Thomas John Robert | Administrateur | Spring Farm Stratford St Mary CO7 6NB Colchester Essex | British | 9903520001 | ||||||
| GRAHAM, Robert | Administrateur | 85 Bridle Path Don Mills FOREIGN Ontario M3c 2pl Canada | Canadian | 31509960001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Bank Plc | 06 avr. 2016 | Churchill Place E14 5HP London 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £138,287 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brèves mentions Nissan primera 1.6 slx. Volvo 445 glta. Volvo 940 wentworth auto. Saab 900SE turbo. Bmw 520I. Toyota carina 1.6GL. Bmw 318IS coupe. Rover 416 sli. Renault 19 16V 3DR. Montego 2.0 lxi estate. Vw golf gl. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £43,157 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brèves mentions Volvo 460GLE saloon. Vw passat 16V estate. Volvo 960 2.4V. saab 9000 2 litre xs. Citroen bx gti 1905CC. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £80161 and all other monies due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The eleven various vehicles as described on form 395 ref M62. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £22068.13 and all other monies due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The two vehicles as described on form 395 ref M53. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £15610 and all other monies due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The two vehicles as described on form 395 ref M52. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £57,137 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brèves mentions Bmw 320ISE. Bmw 316I. Renault 25TXE. Toyota corolla gti 1.6. rover sterling. Volvo 944 gle saloon. Mercedes 230CE. Saab 9000 turbo. Honda accord exi at. Granada 2.0. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £65413 and all other monies due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The eight vehicles as described on form 395 ref M51. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £61,480 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brèves mentions Volvo 940 turbo auto. Peugeot 505 gr 2.0 est. Vw golf clipper conv. Vovo 440 gl. Saab 900T 16S. vauxhall frontera sport. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £125,959 all monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brèves mentions Nissan primera 2.0LS. Jaguar XJ6 3.2 auto. Saab 92 9000 cs 2.0S. range rover vogue V81. Mercedes 230E auto. Mitsubishi colt gli. Vw golf gti. Peugeot 405 grdt est. Nissan primera. Toyota carina 1.6 5DR. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £121,278 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brèves mentions Two mercedes benz 190E 2.0. jaguar XJ6. Vw golf gl auto. Escort 1.6 ghia 16V. montego 2.0 dslx estate. Vauxhall cavalier. Audi 80. honda civic 1.6. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £37,653 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brèves mentions Bmw 325I ase. Mazda 323 1.6F iabs glx. Honda accord 2.0 auto. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 mai 1993 Livré le 18 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £57,974 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brèves mentions Mercedes benz 220E. toyota previa automatic. Peugeot 205 diesel. Nissan serena 1.6LX 4DR. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of deposit | Créé le 04 mai 1990 Livré le 12 mai 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease | |
Brèves mentions The deposit of £1,624,575. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
GERRARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0