TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02183136 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Ian Scott en tant que directeur le 13 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Michael Ian Scott en tant qu'administrateur le 21 août 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Barbara Mary Richmond en tant que directeur le 21 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Helen Davies en tant que directeur le 31 juil. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Timothy Huw Stone en tant qu'administrateur le 31 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Barratt Corporate Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 01 août 2025 | 2 pages | AP04 | ||
Cessation de la nomination de Bethany Ford en tant que secrétaire le 31 juil. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2024 | 1 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Bethany Ford en tant que secrétaire le 30 nov. 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Graham Anthony Cope en tant que secrétaire le 30 nov. 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2023 | 1 pages | AA | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 1 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 1 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 1 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 1 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRATT CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Cartwright Way Forest Business Park Bardon Hill LE67 1UF Coalville Barratt House Leicestershire United Kingdom |
| 160289260001 | ||||||||||
| STONE, Timothy Huw | Administrateur | St David's Park CH5 3RX Flintshire Redrow House United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 297709310001 | |||||||||
| COPE, Graham Anthony | Secrétaire | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | British | 85842880003 | ||||||||||
| EVANS, Stephen Geoffrey | Secrétaire | The Orchard 58 Huddersfield Road Skelmanthorpe HD8 9AS Huddersfield West Yorkshire | British | 3621900001 | ||||||||||
| FORD, Bethany | Secrétaire | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | 316534660001 | |||||||||||
| WALKER, Rhiannon Ellis | Secrétaire | Gatesheath Hall Gatesheath Tattenhall CH3 9AH Chester Cheshire | British | 86070003 | ||||||||||
| BANNISTER, William Henry | Administrateur | 28 Riverside Road West Moors BH22 0LQ Ferndown Dorset | United Kingdom | British | 58990140003 | |||||||||
| BRAND, William John | Administrateur | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | England | British | 5202410003 | |||||||||
| CAMPBELL KELLY, David John | Administrateur | Bridgemere House Yew Tree Close LE8 6BU Willoughby Waterleys Leicestershire | British | 40876330001 | ||||||||||
| DAVIES, Helen | Administrateur | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | United Kingdom | British | 83638070001 | |||||||||
| DAY, Jacqueline May | Administrateur | The Stumps Totteridge Common HP13 7QG High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 42773840001 | |||||||||
| EVANS, Stephen Geoffrey | Administrateur | The Orchard 58 Huddersfield Road Skelmanthorpe HD8 9AS Huddersfield West Yorkshire | England | British | 3621900001 | |||||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Administrateur | 31 Rean Meadow Tattenhall CH3 9PU Chester Cheshire | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||||||
| FLELLO, Paul Ian | Administrateur | Kingsmead Lodge 7a The Green, Great Horwood MK17 0RH Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | 64948520004 | |||||||||
| GIBSON, Barrie John | Administrateur | 14 Kelthorpe Road Ketton PE9 3RS Rutland | United Kingdom | British | 187156090001 | |||||||||
| HADDON, Mark Anthony | Administrateur | 24 Landcross Drive Abington Vale NN3 3LS Northampton Northamptonshire | British | 37400510001 | ||||||||||
| HALL, David George | Administrateur | 7 Octavian Drive Bancroft MK13 0QR Milton Keynes | British | 41519030001 | ||||||||||
| HODGSON, Christopher John | Administrateur | Rose Cottage The Ridge Bossage GL6 8HD Stroud Gloucestershire | England | British | 87716630001 | |||||||||
| LEWIS, Alun Watkin | Administrateur | Pennant 1 Ffordd Dolgoed CH7 1PE Yr Wyddgrug Sir Y Fflint | Wales | British | 37977020001 | |||||||||
| LOCKE, Gregson Horace | Administrateur | North Lea Baker Street OX11 9DD Aston Tirrold Oxfordshire | England | British | 40820130001 | |||||||||
| MAUNDERS, John Ware | Administrateur | Littledown Southdowns Drive Hale WA14 3HR Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 35554380001 | |||||||||
| MICKLEWRIGHT, Graham | Administrateur | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | United Kingdom | British | 98783370001 | |||||||||
| PEAK, James | Administrateur | Adams Lodge 8 Baskerfield Grove Woughton On The Green MK6 3EN Milton Keynes | British | 45884180001 | ||||||||||
| POWELL, Michael Robert | Administrateur | 8 Kentmere Close SK8 4RD Gatley Cheshire | Great Britain | British | 21740050002 | |||||||||
| RICHMOND, Barbara Mary | Administrateur | Redrow House Saint Davids Park CH5 3RX Ewloe Flintshire | United Kingdom | British | 152559820001 | |||||||||
| SCOTT, Michael Ian | Administrateur | Cartwright Way Forest Business Park Bardon Hill LE67 1UF Coalville Barratt House Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 290228130001 | |||||||||
| SHAH, Rajesh | Administrateur | 37 Lippitts Hill LU2 7YN Luton Bedfordshire | England | British | 21593270001 | |||||||||
| SMITH, Geoffrey William Craven | Administrateur | Mendips 7 Abbotts Close NN14 3AW Titchmarsh Northamptonshire | British | 81060430001 | ||||||||||
| STEEL, Peter Morgan | Administrateur | 44 Melfort Drive LU7 2XN Leighton Buzzard Bedfordshire | United Kingdom | British | 76534300001 | |||||||||
| STUBBS, Norman Alan | Administrateur | East Chevin Road LS21 3DD Otley The Stables West Yorkshire | England | British | 1692650001 | |||||||||
| SWANSON, John Stewart Richardson | Administrateur | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British | 4946820001 | |||||||||
| TUTTE, John Frederick | Administrateur | Peters Barn West End, Scaldwell NN6 9JX Northampton Northamptonshire | England | British | 56012720002 | |||||||||
| WARRINGTON, Brian | Administrateur | 10 Gilbert Road WA15 9NR Hale Cheshire | British | 65464000002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb (Cpts) Limited | 06 avr. 2016 | St. Davids Park CH5 3RX Ewloe Redrow House Flintshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0