TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02183240 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Marlborough House Westminster Place York Business Park YO26 6RW York England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 janv. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satisfaction de la charge 021832400013 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Modification des détails de Project Oak Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 janv. 2026 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom à Marlborough House Westminster Place York Business Park York YO26 6RW le 13 janv. 2026 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Project Oak Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 janv. 2026 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Marlborough House Westminster Place York Business Park York YO26 6RW United Kingdom à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT le 06 janv. 2026 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 42 pages | AA | ||||||||||
Statuts | 12 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Inscription de la charge 021832400014, créée le 12 déc. 2025 | 15 pages | MR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ben Richardson en tant que directeur le 31 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jamie Adam Beaumont en tant qu'administrateur le 31 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 42 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 47 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails de Project Oak Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 mai 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 85 Great Portland Street London W1W 7LT England à Marlborough House Westminster Place York Business Park York YO26 6RW le 11 juil. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 65 Great Portland Street London W1W 7LT United Kingdom à 85 Great Portland Street London W1W 7LT le 31 mai 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Marlborough House Westminster Place York Business Park York YO26 6RW United Kingdom à 65 Great Portland Street London W1W 7LT le 30 mai 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 85 Great Portland Street London W1W 7LT England à Marlborough House Westminster Place York Business Park York YO26 6RW le 30 mai 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Vishu Passi en tant que directeur le 14 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Paul Williams en tant qu'administrateur le 13 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 42 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUMONT, Jamie Adam | Administrateur | Westminster Place York Business Park YO26 6RW York Marlborough House England | United Kingdom | British | 268394780001 | |||||||||
| WILLIAMS, Simon Paul | Administrateur | Westminster Place York Business Park YO26 6RW York Marlborough House England | United Kingdom | British | 133579840001 | |||||||||
| FERGUSON, Paul John | Secrétaire | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | British | 84739280002 | ||||||||||
| GODLIMAN, Victoria | Secrétaire | Foston YO60 7QD York Gravel Pit Farm England | 167580980001 | |||||||||||
| HOLMES, Geoffrey John | Secrétaire | Gipsy Corner Rudcarr Lane, Warthill YO19 5TL York | South African | 71232680003 | ||||||||||
| MANUEL PILLAI, Joseph Manoharan | Secrétaire | Shanthy 8 The Mount HA9 9EE Wembley Park Middlesex | British | 58726100001 | ||||||||||
| MILLS, Peter Charles | Secrétaire | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | 191203580001 | |||||||||||
| MITCHELL, Stephen Paul | Secrétaire | 4 Heather Way HG3 2SH Harrogate North Yorkshire | British | 67347440001 | ||||||||||
| POLLOCK, David Timothy Campbell | Secrétaire | 3 Halland Way HA6 2AG Northwood Middlesex | British | 35516100003 | ||||||||||
| RIDLEY, Paul | Secrétaire | 36 Deepdale Avenue YO11 2UF Scarborough North Yorkshire | British | 7852170001 | ||||||||||
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7NQ London 65 England |
| 135207160001 | ||||||||||
| ATKINSON, Rachel Clare | Administrateur | 2 Queens Court Fetter Lane YO1 6EH York North Yorkshire | England | British | 72503190001 | |||||||||
| BLOW, Bridget Penelope | Administrateur | Flat 119 B Central 38 Paradise Street B1 2AF Birmingham West Midlands | England | British | 115125670001 | |||||||||
| COOKE, Ursula | Administrateur | 70 Bootham YO30 7DF York | British | 115125770002 | ||||||||||
| DALE, Nicholas Siegfried | Administrateur | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | England | British | 240399690001 | |||||||||
| DI VENTURA, Angelo Gioacchino | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 137414540001 | |||||||||
| DI VENTURA, Angelo Gioacchino | Administrateur | Chestnut Avenue WD3 4HA Rickmansworth 21 Herts United Kingdom | England | British | 137414540001 | |||||||||
| DICKENS, Timothy | Administrateur | Trelawney House Millfield Lane, Easingwold YO61 3JP York Yorkshire | British | 126846210001 | ||||||||||
| FERGUSON, Paul John | Administrateur | 31 Strensall Road Huntington YO32 9SH York North Yorkshire | England | British | 84739280002 | |||||||||
| FRASER, David John | Administrateur | Bycroft House Mumberry Hill Hare Hatch RG10 8EE Wargrave Berkshire | British | 38663350001 | ||||||||||
| FREWING, Scott Michael | Administrateur | EC2V 7NQ London 65 Gresham Street England | England | British | 214725840001 | |||||||||
| FURBER, Simon Mark | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 83053080001 | |||||||||
| GODLIMAN, Mark | Administrateur | Triune Court Monks Cross Drive Huntington YO32 9GZ York Trustmarque House North Yorkshire England | England | British | 191781880001 | |||||||||
| GODLIMAN, Victoria | Administrateur | Foston YO60 7QD York Gravel Pit Farm England | England | British | 83684440003 | |||||||||
| HADDOW, Scott William | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 121651070002 | |||||||||
| HADDOW, Scott William | Administrateur | Chelford Road WA16 8LY Knutsford Spinney End Cheshire Great Britain | England | British | 121651070002 | |||||||||
| JARVIS, Ian Edward | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 184235890001 | |||||||||
| JOYCE, Dermot James | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 181301350001 | |||||||||
| LLOYD, Colin Thomas | Administrateur | Fawke Common Underriver TN15 0JX Sevenoaks Fawke House Kent | England | British | 3616430001 | |||||||||
| MANUEL PILLAI, Joseph Manoharan | Administrateur | Shanthy 8 The Mount HA9 9EE Wembley Park Middlesex | British | 58726100001 | ||||||||||
| MCBRINN, William Stephen | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 161340530001 | |||||||||
| MCDONAGH, Stephen Anthony | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 22036920004 | |||||||||
| METCALFE, Richard Crosby, Mr. | Administrateur | Ryehill Cottage Lyndhurst Road SO42 7YE Beaulieu Hampshire | United Kingdom | British | 73646130001 | |||||||||
| MILLER, Ross Charles | Administrateur | Primrose Farm Hagg Lane Dunnington YO19 5PE York Yorkshire | England | British | 84739210001 | |||||||||
| PASSI, Vishu | Administrateur | Great Portland Street W1W 7LT London 85 England | England | British | 294393200001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Oak Bidco Limited | 31 mars 2022 | Westminster Place York Business Park YO26 6RW York Marlborough House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Capita Holdings Limited | 21 juin 2016 | Gresham Street EC2V 7NQ London 65 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ardbid Limited | 06 avr. 2016 | 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds Ernst Young Llp Yorkshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0