BARTEND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBARTEND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02183962
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BARTEND LIMITED ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BARTEND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BEGBIES TRAYNOR (LONDON) LLP
    40 Bank Street
    31st Floor
    E14 5NR London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BARTEND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LONDON GRAPHIC SUPPLIES LIMITED14 août 200014 août 2000
    BARTEND LIMITED27 oct. 198727 oct. 1987

    Quels sont les derniers comptes de BARTEND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BARTEND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    21 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 févr. 2019

    22 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 févr. 2018

    24 pagesLIQ03

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    7 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 09 févr. 2017

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 16-18 Shelton Street London WC2H 9JL England à C/O Begbies Traynor (London) Llp 40 Bank Street 31st Floor London E14 5NR le 13 janv. 2017

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name11 janv. 2017

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Satisfaction de la charge 021839620010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 021839620010

    1 pagesMR05

    Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Inscription de la charge 021839620010, créée le 21 janv. 2016

    49 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    21 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 2 Western Avenue Business Park Mansfield Road Acton London W3 0BZ à 16-18 Shelton Street London WC2H 9JL le 21 déc. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 juil. 2015

    État du capital au 22 juil. 2015

    • Capital: GBP 44,679.3
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    20 pagesAA

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 août 2014

    État du capital au 01 août 2014

    • Capital: GBP 44,679.3
    SH01

    Nomination de Mr Nigel Edwards en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 août 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 08 août 2013

    SH01

    Cessation de la nomination de David Cox en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Cox en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BARTEND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHAH, Kiren Narshi
    c/o Begbies Traynor (London) Llp
    Bank Street
    31st Floor
    E14 5NR London
    40
    England
    Secrétaire
    c/o Begbies Traynor (London) Llp
    Bank Street
    31st Floor
    E14 5NR London
    40
    England
    172312760001
    EDWARDS, Nigel
    c/o Begbies Traynor (London) Llp
    Bank Street
    31st Floor
    E14 5NR London
    40
    England
    Administrateur
    c/o Begbies Traynor (London) Llp
    Bank Street
    31st Floor
    E14 5NR London
    40
    England
    EnglandBritishDirector186124190001
    SHAH, Kiren Narshi
    c/o Begbies Traynor (London) Llp
    Bank Street
    31st Floor
    E14 5NR London
    40
    England
    Administrateur
    c/o Begbies Traynor (London) Llp
    Bank Street
    31st Floor
    E14 5NR London
    40
    England
    EnglandBritishChartered Accountant60174500001
    ALLEN, Peter Richard
    25 King Edwards Gardens
    Acton Hill
    W3 9RF London
    Secrétaire
    25 King Edwards Gardens
    Acton Hill
    W3 9RF London
    British15089290002
    COX, David Raymond
    2 Western Avenue Business Park
    Mansfield Road
    W3 0BZ Acton
    London
    Secrétaire
    2 Western Avenue Business Park
    Mansfield Road
    W3 0BZ Acton
    London
    170284120001
    ALLEN, Peter Richard
    25 King Edwards Gardens
    Acton Hill
    W3 9RF London
    Administrateur
    25 King Edwards Gardens
    Acton Hill
    W3 9RF London
    EnglandBritishChartered Accountant15089290002
    CHRISTIANSEN, Gordon Peter
    Meadow View 39 Long Reach
    West Horsley
    KT24 6LZ Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Meadow View 39 Long Reach
    West Horsley
    KT24 6LZ Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishSales Director79626160001
    COX, David
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishNone70818680001
    COZENS, Peter
    1 Thetis Terrace
    TW9 3AU Richmond
    Surrey
    Administrateur
    1 Thetis Terrace
    TW9 3AU Richmond
    Surrey
    BritishCompany Director118912710001
    EDWARDS, Stephen Peter
    2 Western Avenue Business Park
    Mansfield Road
    W3 0BZ Acton
    London
    Administrateur
    2 Western Avenue Business Park
    Mansfield Road
    W3 0BZ Acton
    London
    United KingdomBritishVenture Capitalist147275950001
    HARBIGE, Henry John
    8 Montgomery Tregarthen Place
    KT22 7XL Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    8 Montgomery Tregarthen Place
    KT22 7XL Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director15089300006
    JELBART, Martin Wallis
    7 Benenden Green
    BR2 9DJ Bromley
    Kent
    Administrateur
    7 Benenden Green
    BR2 9DJ Bromley
    Kent
    EnglandBritishInvestment Manager7579890001
    MARSLAND, Christopher Robert
    24 Barrowgate Road
    Chiswick
    W4 4QY London
    Administrateur
    24 Barrowgate Road
    Chiswick
    W4 4QY London
    BritishCompany Director15089310004
    ROWLANDS, Simon Nicholas
    28 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RY London
    Administrateur
    28 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RY London
    BritishInvestment Manager40561640001
    ROYLES, Marina Isobel
    72 Axminster Road
    Holloway
    N7 6BS London
    Administrateur
    72 Axminster Road
    Holloway
    N7 6BS London
    BritishSales Director58842460001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BARTEND LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Colway Limited
    Shelton Street
    WC2H 9JL London
    16-18 Shelton Street
    England
    19 juil. 2016
    Shelton Street
    WC2H 9JL London
    16-18 Shelton Street
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementN/A
    Numéro d'enregistrement05693481
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BARTEND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 21 janv. 2016
    Livré le 22 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All freehold and leasehold property now or at any time in the future owned by the company. All intellectual property now or at any time in the future owned by the company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Core Capital I LP
    Transactions
    • 22 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 sept. 2016Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 10 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 05 oct. 2012
    Livré le 11 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 mai 2006
    Livré le 12 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of 16-18 shelton street london t/no NGL749860 and 18 station road harrogate north yorkshire t/no NYK80548 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 12 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 23 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 04 nov. 2002
    Livré le 09 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 09 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 janv. 1998
    Livré le 05 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP; Acting by Its General Partner Abn Amro Causeway(Guernsey) LTD. as Security Beneficiary ("the Security Beneficiary")
    Transactions
    • 05 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 août 1991
    Livré le 02 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lease 18 station parade, harrogate, north yorkshire title no nyk 80548 and the proceeds of sale thereof with a:-. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 03 oct. 1990
    Livré le 22 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/as 1 to 6 batemans row london EC2A and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juin 1990
    Livré le 06 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property k/as units 9 and 10 mckay trading estate london W10 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juin 1990
    Livré le 06 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1-6 batemans row, l/b of hackney title no:- ngl 208976 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 27 avr. 1988
    Livré le 05 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BARTEND LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 févr. 2017Commencement of winding up
    28 avr. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kirstie Jane Provan
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Gary Paul Shankland
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0