BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED

BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02184171
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLS 76 LIMITED27 oct. 198727 oct. 1987

    Quels sont les derniers comptes de BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mai 2016

    État du capital au 17 mai 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Martin Lee Thompson en tant que secrétaire le 13 mai 2016

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Patricia Davison le 01 août 2014

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Steven John Boultbee Brooks en tant que directeur le 01 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Adam Pinnell en tant que secrétaire le 13 mai 2016

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Clive Ensor Boultbee Brooks le 01 août 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Charmaine Joan Boultbee Brooks le 01 août 2014

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2015

    État du capital au 05 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    13 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 1St Floor Kemble House 36-39 Broad Street Hereford HR4 9AR à 2Nd Floor Broadway House 32-35 Broad Street Hereford HR4 9AR le 25 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THOMPSON, Martin Lee
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    Secrétaire
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    208225100001
    BOULTBEE BROOKS, Charmaine Joan
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    Administrateur
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    United KingdomBritishCompany Director81478130001
    BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    Administrateur
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    United KingdomBritishCompany Director82993640001
    DAVISON, Patricia
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    Administrateur
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    EnglandBritishCompany Director71041130003
    ROBERTS, Lee
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant61138670002
    BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor
    Floor Kemble House
    36-39 Broad Street Hereford
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor Kemble House
    36-39 Broad Street Hereford
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    British82993640001
    KING, John William, Group Captain
    36 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    Secrétaire
    36 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LU London
    British46043270001
    PINNELL, Adam
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Broadway House
    32-35 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor
    United Kingdom
    166733490001
    BOULTBEE BROOKS, Steven John
    Floor Kemble House
    36-39 Broad Street Hereford
    HR4 9AR Herefordshire
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor Kemble House
    36-39 Broad Street Hereford
    HR4 9AR Herefordshire
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director67458340004
    BROOKS, John Ensor Boultbee
    Floor Kemble House
    36-39 Broad Street Hereford
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor Kemble House
    36-39 Broad Street Hereford
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director11249920002
    JEFFERY, Nigel John
    Floor Kemble House
    36-39 Broad Street Hereford
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor Kemble House
    36-39 Broad Street Hereford
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector65718910001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Boultbee Finance (Shelf 1) Limited
    32-35 Borad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor Broadway House
    England
    06 avr. 2016
    32-35 Borad Street
    HR4 9AR Hereford
    2nd Floor Broadway House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BOULTBEE TRADING COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment
    Créé le 24 avr. 2012
    Livré le 03 mai 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from boultbee construction limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all moneys from time to time owing or incurred under the lease or leases in respect of f/h plots a and b and units 17, 18, 20 and 21 pershore road, stirchley t/no WM315174 and f/h units 19 and 22 pershore road, stirchley t/no WM328939. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aviva Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 03 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Supplemental deed
    Créé le 24 avr. 2012
    Livré le 03 mai 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from boultbee construction limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H plots a and b and units 17, 18, 20 and 21 pershore road, stirchley t/no WM315174 and f/h units 19 and 22 pershore road, stirchley t/no WM328939; including all buildings, erections and fixtures and fittings (but excluding tenants’ fixtures and fittings) and fixed plant, equipment and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights options covenants indemnities guarantees warranties and conditions affecting the same. By way of fixed charge all monies deposited with the trustee, by way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Personnes ayant droit
    • Aviva Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 03 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dated 29 october 1997) and
    Créé le 28 janv. 2003
    Livré le 01 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from bishop brook investments limited and gls 153 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land k/a 1 old forge ind. Est. T/no HW99625 and HW188624 and l/h land k/a site 3C crompton way segensworth HP270506 and f/h land k/a 17-22 pershore road stirchley birmingham t/no WM315714 and WM328939 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 01 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 28 janv. 2003
    Livré le 01 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from moonfleet properties limited and gls 153 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s of f/h land k/a 17-22 pershore road stirchley birmingham WM315714 and WM328939.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 01 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 19 mars 1999
    Livré le 02 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 29 october 1997
    Brèves mentions
    The properties listed below together with all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases, underleases, tenancies, agreements to lease, rights, covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. F/h 573 wallisdown road poole dorset t/n-DT27285.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 02 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 01 mai 1998
    Livré le 16 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 29TH october 1997
    Brèves mentions
    The properties listed below together with all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases, underleases, tenancies, agreements to lease, rights, covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. Units 3, 4, 5, 8 and 9 edenbridge trading centre edenbridge kent - K501990. Units 8, 9, 10, 14, 19 and 20 repton court burnt mills industrial estate basildon essex - EX386341. Perry park industrial estate walsall road perry bar birmingham - EX386341. By way of floating charge the whole of the company's undertaking.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 16 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment by way of charge
    Créé le 01 mai 1998
    Livré le 16 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies, obligations and liabilites whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by boultbee construction limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of boultbee construction limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, the norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed moneys by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Brèves mentions
    The company assigns by way of charge all the rights, titles, benefits and interests and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/S.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 16 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of yearly rents
    Créé le 19 mai 1997
    Livré le 24 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Any and all sums (whether principal, interest, fees or otherwise) due or to become due from the company or any person who is a party to any related secrutiy document (as defined) to the chargee under or pursuant to the terms of an agreement constituted by a facility letter from the chargee to the company dated 1ST may 1997 this assignment or any other related security document (as defined) or on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of absolute assignment to the bank all:-the company's right title and interest in and to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the existing lease of the land and premises situate and k/a units 3, 4, 5, 8 & 9 edenbridge trading estate edenbridge kent and more particularly listed in the assignment and any leases of such land and premises or any part thereof subsequently granted within 21 years of the assignment.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 19 mai 1997
    Livré le 24 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all that f/h premises k/a units 3, 4, 5, 8 & 9 edenbridge trading estate on the south side of hever road edenbridge t/n-K501990, including all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon (other than trade machinery as defined in section 5 of the bills of sale act 1878).
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 1997
    Livré le 24 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the copmpany whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Principal charge of rents
    Créé le 30 avr. 1997
    Livré le 03 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rents now owing or hereafter to become owing to the company in respect of the f/h land k/a the perry park industrial estate,walsall road,perry barr,birmingham,west midlands.t/no.WK129807.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 1997
    Livré le 03 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 1997
    Livré le 03 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that the f/h land situate and k/a perry park industrial estate,401 walsall road,perry park,birmingham,west midlands.t/no.WK129807 including all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon (other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878).
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 1996
    Livré le 06 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 5/9 selly oak industrial estate elliot road birmingham west midlands t/n WM531573.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 26 janv. 1996
    Livré le 06 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 sept. 1989
    Livré le 04 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 19 quaker square bethnal green l/b tower hamlets t/ns egl 190935.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0