PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED

PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02187130
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o CAPITAL PROPERTIES (UK) LTD
    Level 5 Tower 12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 sept. 2014

    État du capital au 12 sept. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2013 au 31 déc. 2012

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Capital Properties (Uk) Ltd 5th Floor Tower 12 Avenue North 18-20 Bridge Street Manchester M3 3BZ United Kingdom le 14 oct. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Frederick Paul Graham Watson le 18 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Julian Ingall le 18 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2012 au 30 juin 2013

    1 pagesAA01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor 33 Cork Street London W1S 3NQ England le 17 mai 2013

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Martin Bell en tant que secrétaire le 05 avr. 2012

    1 pagesTM02

    Nomination de Andy Campbell en tant que secrétaire le 05 avr. 2012

    1 pagesAP03

    Nomination de Mr Martin Bell en tant que secrétaire le 13 déc. 2011

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Suresh Premji Gorasia en tant que secrétaire le 13 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Stuart Paul Lyell en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 2 Hardman Street Manchester M3 3HF United Kingdom

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 1 Cavendish Place London W1G 0QF le 10 févr. 2011

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Suresh Premji Gorasia en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMPBELL, Andy
    c/o Capital Properties (Uk) Ltd
    12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Level 5 Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Capital Properties (Uk) Ltd
    12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Level 5 Tower
    United Kingdom
    168177680001
    GRAHAM WATSON, Frederick Paul
    c/o Capital Properties (Uk) Ltd
    12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Level 5 Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Capital Properties (Uk) Ltd
    12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Level 5 Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish80482690001
    INGALL, Michael Julian
    c/o Capital Properties (Uk) Ltd
    12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Level 5 Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Capital Properties (Uk) Ltd
    12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Level 5 Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish46465490003
    LYELL, Stuart Paul
    c/o Capital Properties (Uk) Ltd
    12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Level 5 Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Capital Properties (Uk) Ltd
    12
    18-22 Bridge Street Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Level 5 Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish158548330001
    ASHURST, John Richard
    29 Broadhurst
    KT21 1QB Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    29 Broadhurst
    KT21 1QB Ashtead
    Surrey
    British109128490001
    BELL, Martin
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    1st Floor
    England
    Secrétaire
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    1st Floor
    England
    165335640001
    BOOTH, Peter James
    Windy Ridge
    Hermitage Road Mid Higham
    ME3 7NF Rochester
    Kent
    Secrétaire
    Windy Ridge
    Hermitage Road Mid Higham
    ME3 7NF Rochester
    Kent
    British3896380002
    GARDNER, Richard Alan
    Tudor Dene Church Lane
    TN12 5JH East Peckham
    Kent
    Secrétaire
    Tudor Dene Church Lane
    TN12 5JH East Peckham
    Kent
    British72005960001
    GORASIA, Suresh Premji
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    1st Floor
    England
    Secrétaire
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    1st Floor
    England
    155047770001
    STAPLETON, Valerie Georgina
    Four Winds
    46 Brattlewod
    TN13 1QU Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Four Winds
    46 Brattlewod
    TN13 1QU Sevenoaks
    Kent
    British72005580003
    WARREN, Neil Ian
    2 Devon Court
    DA4 9EP Sutton At Hone
    Kent
    Secrétaire
    2 Devon Court
    DA4 9EP Sutton At Hone
    Kent
    British72005900001
    BOOTH, Peter James
    Windy Ridge
    Hermitage Road Mid Higham
    ME3 7NF Rochester
    Kent
    Administrateur
    Windy Ridge
    Hermitage Road Mid Higham
    ME3 7NF Rochester
    Kent
    EnglandBritish3896380002
    COLVERD, Robert Cecil
    28 Crest View Drive
    Petts Wood
    BR5 1BY Orpington
    Kent
    Administrateur
    28 Crest View Drive
    Petts Wood
    BR5 1BY Orpington
    Kent
    British5199620001
    GARDNER, Richard Alan
    Tudor Dene Church Lane
    TN12 5JH East Peckham
    Kent
    Administrateur
    Tudor Dene Church Lane
    TN12 5JH East Peckham
    Kent
    British72005960001
    STANTON, Howard Terence
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    Administrateur
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish52013920003
    STAPLETON, John
    Four Winds
    46 Brattlewood
    TN13 1QU Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Four Winds
    46 Brattlewood
    TN13 1QU Sevenoaks
    Kent
    British5199630002
    TROTT, Gary Keith
    1 Canterbury Close
    SS6 9PS Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    1 Canterbury Close
    SS6 9PS Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritish108358480001
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish1604580001
    WARREN, Neil Ian
    2 Devon Court
    DA4 9EP Sutton At Hone
    Kent
    Administrateur
    2 Devon Court
    DA4 9EP Sutton At Hone
    Kent
    EnglandBritish72005900001

    PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge by the company and as trustee for the company
    Créé le 19 févr. 2002
    Livré le 21 févr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the north side of yarmouth road thorpe st. Andrew norwich norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge by the company and as trustee for the company
    Créé le 19 févr. 2002
    Livré le 20 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H farm kingsnorth land on the north side of the road leading from kingnorth to sevnington land at bilham farm mersham and land at kingsnorth ashford.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 avr. 1999
    Livré le 06 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or pelham homes limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (I) finn farm,kingsnorth,kent;(ii) bilham farm,mersham,ashford,kent;(iii) land on north side of a road leading fron kingsnorth to sevington,cheeseman's green,kingsnorth,kent; (iv) land at kingsnorth,ashford,kent; t/nos K166974,K541709,K552570 and K633814.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 20 avr. 1999
    Livré le 28 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or pelham homes limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of assignment all that the principal sum owing on the security of the mortgage mentioned in the schedule hereto and all interest now due or to become due thereon and the benefit of all securities for the same.by way of legal mortgage but subject to such rights of redemption as the same are now subject to by virtue of the said mortgage,all the property comprised therein.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juin 1998
    Livré le 29 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or pelham homes limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Broadland business park,norwich,norfolk; t/nos NK199906 and NK200967.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0