PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02187130 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o CAPITAL PROPERTIES (UK) LTD Level 5 Tower 12 18-22 Bridge Street Spinningfields M3 3BZ Manchester |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 août 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 10 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2013 au 31 déc. 2012 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Capital Properties (Uk) Ltd 5th Floor Tower 12 Avenue North 18-20 Bridge Street Manchester M3 3BZ United Kingdom le 14 oct. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Frederick Paul Graham Watson le 18 sept. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Julian Ingall le 18 sept. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2012 au 30 juin 2013 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1st Floor 33 Cork Street London W1S 3NQ England le 17 mai 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Bell en tant que secrétaire le 05 avr. 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Andy Campbell en tant que secrétaire le 05 avr. 2012 | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Martin Bell en tant que secrétaire le 13 déc. 2011 | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Suresh Premji Gorasia en tant que secrétaire le 13 déc. 2011 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stuart Paul Lyell en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 2 Hardman Street Manchester M3 3HF United Kingdom | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Cavendish Place London W1G 0QF le 10 févr. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Suresh Premji Gorasia en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL, Andy | Secrétaire | c/o Capital Properties (Uk) Ltd 12 18-22 Bridge Street Spinningfields M3 3BZ Manchester Level 5 Tower United Kingdom | 168177680001 | |||||||
| GRAHAM WATSON, Frederick Paul | Administrateur | c/o Capital Properties (Uk) Ltd 12 18-22 Bridge Street Spinningfields M3 3BZ Manchester Level 5 Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 80482690001 | |||||
| INGALL, Michael Julian | Administrateur | c/o Capital Properties (Uk) Ltd 12 18-22 Bridge Street Spinningfields M3 3BZ Manchester Level 5 Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 46465490003 | |||||
| LYELL, Stuart Paul | Administrateur | c/o Capital Properties (Uk) Ltd 12 18-22 Bridge Street Spinningfields M3 3BZ Manchester Level 5 Tower United Kingdom | England | British | 158548330001 | |||||
| ASHURST, John Richard | Secrétaire | 29 Broadhurst KT21 1QB Ashtead Surrey | British | 109128490001 | ||||||
| BELL, Martin | Secrétaire | 33 Cork Street W1S 3NQ London 1st Floor England | 165335640001 | |||||||
| BOOTH, Peter James | Secrétaire | Windy Ridge Hermitage Road Mid Higham ME3 7NF Rochester Kent | British | 3896380002 | ||||||
| GARDNER, Richard Alan | Secrétaire | Tudor Dene Church Lane TN12 5JH East Peckham Kent | British | 72005960001 | ||||||
| GORASIA, Suresh Premji | Secrétaire | 33 Cork Street W1S 3NQ London 1st Floor England | 155047770001 | |||||||
| STAPLETON, Valerie Georgina | Secrétaire | Four Winds 46 Brattlewod TN13 1QU Sevenoaks Kent | British | 72005580003 | ||||||
| WARREN, Neil Ian | Secrétaire | 2 Devon Court DA4 9EP Sutton At Hone Kent | British | 72005900001 | ||||||
| BOOTH, Peter James | Administrateur | Windy Ridge Hermitage Road Mid Higham ME3 7NF Rochester Kent | England | British | 3896380002 | |||||
| COLVERD, Robert Cecil | Administrateur | 28 Crest View Drive Petts Wood BR5 1BY Orpington Kent | British | 5199620001 | ||||||
| GARDNER, Richard Alan | Administrateur | Tudor Dene Church Lane TN12 5JH East Peckham Kent | British | 72005960001 | ||||||
| STANTON, Howard Terence | Administrateur | 96 Manor Road IG7 5PQ Chigwell Essex | United Kingdom | British | 52013920003 | |||||
| STAPLETON, John | Administrateur | Four Winds 46 Brattlewood TN13 1QU Sevenoaks Kent | British | 5199630002 | ||||||
| TROTT, Gary Keith | Administrateur | 1 Canterbury Close SS6 9PS Rayleigh Essex | United Kingdom | British | 108358480001 | |||||
| TURNBULL, Nigel James Cavers | Administrateur | 17 Salisbury Avenue AL5 2QF Harpenden Hertfordshire | England | British | 1604580001 | |||||
| WARREN, Neil Ian | Administrateur | 2 Devon Court DA4 9EP Sutton At Hone Kent | England | British | 72005900001 |
PELHAM HOMES DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge by the company and as trustee for the company | Créé le 19 févr. 2002 Livré le 21 févr. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a land on the north side of yarmouth road thorpe st. Andrew norwich norfolk. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge by the company and as trustee for the company | Créé le 19 févr. 2002 Livré le 20 févr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H farm kingsnorth land on the north side of the road leading from kingnorth to sevnington land at bilham farm mersham and land at kingsnorth ashford. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 29 avr. 1999 Livré le 06 mai 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or pelham homes limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (I) finn farm,kingsnorth,kent;(ii) bilham farm,mersham,ashford,kent;(iii) land on north side of a road leading fron kingsnorth to sevington,cheeseman's green,kingsnorth,kent; (iv) land at kingsnorth,ashford,kent; t/nos K166974,K541709,K552570 and K633814. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Sub-mortgage | Créé le 20 avr. 1999 Livré le 28 avr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or pelham homes limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of assignment all that the principal sum owing on the security of the mortgage mentioned in the schedule hereto and all interest now due or to become due thereon and the benefit of all securities for the same.by way of legal mortgage but subject to such rights of redemption as the same are now subject to by virtue of the said mortgage,all the property comprised therein.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 18 juin 1998 Livré le 29 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or pelham homes limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Broadland business park,norwich,norfolk; t/nos NK199906 and NK200967. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0